Buscador CIF Logo

Actos BORME Amla Explotaciones Turisticas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Amla Explotaciones Turisticas Sa

Actos BORME Amla Explotaciones Turisticas Sa - A83791558

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Amla Explotaciones Turisticas Sa con CIF A83791558

馃敊 Perfil de Amla Explotaciones Turisticas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Amla Explotaciones Turisticas Sa

16 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: SALVA ROSSELLO MARTA;CARBONELL CIFRE MATEO;DOPICO CESAR KATHERINE. Datosregistrales. T 26765 , F 26, S 8, H M 342582, I/A 69 ( 9.03.23).

15 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: CRUDO MARTINEZ FEDERICO;SALVA ROSSELLO MARTA. Datos registrales. T 26765 , F 25, S 8,H M 342582, I/A 68 ( 8.03.23).

16 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Auditor: MOYA AUDITORIA BALEAR SLP. Datos registrales. T 26765 , F 25, S 8, H M 342582, I/A 67 ( 9.09.22).

01 de Agosto de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 411/2006. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 14/06/2022. Auto de conclusi贸n delconcurso. Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID. Juez: MOISESGUILLAMON RUIZ. Resoluciones: MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, SE DECLARA LA CONCLUSIONDEL CONCURSO, EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES, EL CESE DE LAS LIMITACIONES A LAS FACULTADES DEADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR, Y LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LA DECLARACION DECONCURSO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 411/2006. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 14/06/2022. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID. Juez:MOISES GUILLAMON RUIZ. Datos registrales. T 26765 , F 25, S 8, H M 342582, I/A 66 (22.07.22).

28 de Junio de 2021
Reelecciones. Consejero: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS;CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUELANGEL;DIAMANTOPOULOS EFSTRATIOS. Presidente: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Vicepresid.: CARRILLO SZYMANSKASUSANA MARIA. Secretario: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL. Vicesecret.: DIAMANTOPOULOS EFSTRATIOS. Con.Delegado:CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 26765 , F 24, S 8, H M 342582, I/A 65 (21.06.21).

10 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: MOYA AUDITORIA BALEAR SLP. Datos registrales. T 26765 , F 24, S 8, H M 342582, I/A 64 ( 3.10.19).

02 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: COZAR CHILLERON MARIA ADORACION. Datos registrales. T 26765 , F 23, S 8, H M 342582, I/A62 (26.03.19).

Revocaciones. Apoderado: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZEMILIO;ESCA脩O ALCOZ BEGO脩A. Nombramientos. Apo.Manc.: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLOMIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZ EMILIO;COZAR CHILLERON MARIA ADORACION;ESCA脩O ALCOZ BEGO脩A. Datosregistrales. T 26765 , F 24, S 8, H M 342582, I/A 63 (26.03.19).

15 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CARBONELL CIFRE MATEO;DOPICO CESAR KATHERINE. Datos registrales. T 26765 , F 22, S 8,H M 342582, I/A 61 ( 7.02.18).

29 de Enero de 2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HOTELES GLOBALES SA. Datos registrales. T 26765 , F 22, S 8,H M 342582, I/A 60 (19.01.18).

25 de Octubre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 42.091.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T26765 , F 22, S 8, H M 342582, I/A 59 (18.10.17).

08 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZEMILIO;ESCA脩O ALCOZ BEGO脩A. Nombramientos. Apoderado: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLOMIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZ EMILIO;ESCA脩O ALCOZ BEGO脩A. Datos registrales. T 26765 , F 21, S 8, H M 342582, I/A 58(26.04.17).

28 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZEMILIO;ESCA脩O ALCOZ BEGO脩A. Datos registrales. T 26765 , F 21, S 8, H M 342582, I/A 57 (21.02.17).

07 de Octubre de 2016
Nombramientos. Auditor: MOYA AUDITORIA BALEAR SLP. Datos registrales. T 26765 , F 21, S 8, H M 342582, I/A 56 (29.09.16).

25 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;RAMOS GOMEZEMILIO;DIAMANTOPOULOS EFSTRATIOS. Datos registrales. T 26765 , F 19, S 8, H M 342582, I/A 54 (17.09.15).

Revocaciones. Apoderado: ORTIZ ORTEGA FRANCISCO;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIOMIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLAJULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZSOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;LOPEZCARRILLO MIGUEL ANGEL;MARTINEZ SOLA JULIO MIGUEL;MARTIN JIMENEZ FELIX JAVIER;LOPEZ CARRILLO MIGUELANGEL;SASTRE FE JAIME;RAMOS GOMEZ EMILIO. Datos registrales. T 26765 , F 20, S 8, H M 342582, I/A 55 (17.09.15).

24 de Septiembre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OPTURSA MANAGEMENT SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRILLOBENITEZ JOSE LUIS;CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;PEREZ OCA脩A PASCUAL.Presidente: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Secretario: PEREZ OCA脩A PASCUAL. Vicepresid.: CARRILLO SZYMANSKA SUSANAMARIA. Vicesecret.: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS;CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUELANGEL;DIAMANTOPOULOS EFSTRATIOS. Presidente: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Vicepresid.: CARRILLO SZYMANSKASUSANA MARIA. Secretario: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL. Vicesecret.: DIAMANTOPOULOS EFSTRATIOS. Con.Delegado:CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 19潞 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.. Ampliacion del objeto social. La construcci贸n, ampliaci贸n, compra, venta, renovaci贸n, explotaci贸n directa,arrendamiento, management, renting o leasing de Hoteles, Apartahoteles, Apartamentos Tur铆sticos. Parques Acu谩ticos, Bares,Restaurantes. Salas de Fiesta, Discotecas y cualquier otro tipo de Establecimiento Tur铆stico. Datos registrales. T 26765 , F 17, S 8, HM 342582, I/A 53 (16.09.15).

16 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Presidente: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Consejero: LOPEZCARRILLO MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS.Consejero: PEREZ OCA脩A PASCUAL. Secretario: PEREZ OCA脩A PASCUAL. Nombramientos. Consejero: CARRILLO BENITEZJOSE LUIS;CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA;LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;PEREZ OCA脩A PASCUAL. Presidente:CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Secretario: PEREZ OCA脩A PASCUAL. Vicepresid.: CARRILLO SZYMANSKA SUSANA MARIA.Vicesecret.: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: CARRILLO BENITEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 26765 , F16, S 8, H M 342582, I/A 52 ( 6.02.15).

20 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Auditor: SERAUDIT AUDITORES S L P. Nombramientos. Auditor: MOYA AUDITORIA BALEAR SL. Datosregistrales. T 26765 , F 16, S 8, H M 342582, I/A 51 ( 9.01.14).

22 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL;SASTRE FE JAIME;RAMOS GOMEZ EMILIO. Datos registrales.T 26765 , F 15, S 8, H M 342582, I/A 50 (13.02.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n