Actos BORME de Amnet Spain Sl
16 de Noviembre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 31525 , F 44, S 8, H M 567376, I/A 13 ( 8.11.21).
21 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: COCERO MORA ELENA VICTORIA. SecreNoConsj: DE LA FUENTE CHISCANO MARTA.Nombramientos. SecreNoConsj: COCERO MORA ELENA VICTORIA. Datos registrales. T 31525 , F 44, S 8, H M 567376, I/A 12(14.09.21).
03 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31525 , F 43, S 8, H M 567376, I/A 11 (26.11.20).
29 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: NARANJO ERIK HAGGBLOM. Nombramientos. VsecrNoConsj: COCERO MORA ELENAVICTORIA. Consejero: ALONSO FERNANDEZ RAMON. Datos registrales. T 31525 , F 41, S 8, H M 567376, I/A 9 (22.04.19).
Revocaciones. Apoderado: GAMEZ CARRASCO HELENA SONIA;FREIRE DE ANDRADE ANDRE CAMARINHA;NARANJO ERIKHAGGBLOM;MAJAN GIL ANGEL MANUEL;BOLOIX BAGO FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: GAMEZ CARRASCOHELENA SONIA;MAJAN GIL ANGEL MANUEL;HEVIA-CAMPOMANES RUBIO BLANCA;GAMEZ CARRASCO HELENASONIA;MAJAN GIL ANGEL MANUEL;HEVIA-CAMPOMANES RUBIO BLANCA;ALONSO FERNANDEZ RAMON;MARTINEZ DELUCAS RAFAEL;COCERO MORA ELENA VICTORIA;LAGARON MARTIN EDUARDO JOSE. Datos registrales. T 31525 , F 42, S 8,H M 567376, I/A 10 (22.04.19).
30 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: SENDRA PLANELLO ROGER. Datos registrales. T 31525 , F 41, S 8, H M 567376, I/A 8 (23.05.18).
18 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31525 ,F 41, S 8, H M 567376, I/A 7 ( 9.01.18).
30 de Agosto de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 97.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 31525 , F 40, S 8, HM 567376, I/A 6 (23.08.17).
05 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31525 , F 40, S 8, H M 567376, I/A 5 (27.06.17).
26 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. 17. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 31525 , F 40, S 8, H M 567376, I/A 4(17.12.14).
24 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RAYON CASTILLA DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA FUENTE CHISCANOMARTA. Datos registrales. T 31525 , F 39, S 8, H M 567376, I/A 3 (14.04.14).
29 de Octubre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.07.13. Objeto social: El ejercicio de actividades publicitarias y, particularmente, elejercicio de las actividades propias de una Agencia de Publicidad General y Agencia de Medios, tanto online como offline: Domicilio:GTA DEL MAR CARIBE 1 - AVENIDA PICEAS, 26, "EDIFIC (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: AEGIS MEDIA IBERIA SL. Nombramientos. Consejero: FREIRE DE ANDRADE ANDRE CAMARINHA. Presidente:FREIRE DE ANDRADE ANDRE CAMARINHA. Con.Delegado: FREIRE DE ANDRADE ANDRE CAMARINHA. Consejero: GAMEZCARRASCO HELENA SONIA;NARANJO ERIK HAGGBLOM. SecreNoConsj: RAYON CASTILLA DAVID. Datos registrales. T 31525, F 35, S 8, H M 567376, I/A 1 (18.10.13).
Nombramientos. Apoderado: GAMEZ CARRASCO HELENA SONIA;FREIRE DE ANDRADE ANDRE CAMARINHA;NARANJO ERIKHAGGBLOM;MAJAN GIL ANGEL MANUEL;BOLOIX BAGO FERNANDO;SENDRA PLANELLO ROGER. Datos registrales. T 31525 ,F 38, S 8, H M 567376, I/A 2 (18.10.13).