Buscador CIF Logo

Actos BORME Ancomar Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ancomar Sl

Actos BORME Ancomar Sl - B58443227

Tenemos registrados 5 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Ancomar Sl con CIF B58443227

馃敊 Perfil de Ancomar Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Ancomar Sl

08 de Mayo de 2013
Revocaciones. ADM.UNICO: MONTSERRAT ZAFRA CARLOS ALBERTO. Nombramientos. CONSEJERO: ORTOLL ZARAGOZAMARIA INMACULADA. PRESIDENTE: ORTOLL ZARAGOZA MARIA INMACULADA. CONSEJERO: PEREZ ROSALES VALDESRAFAEL. VICEPRESIDEN: PEREZ ROSALES VALDES RAFAEL. CONSEJERO: PEREZ ROSALES VALDES MIGUEL;PARELLADADE CARALT JOSE IGNACIO. SECRETARIO: PARELLADA DE CARALT JOSE IGNACIO. CONSEJERO: MONTSERRAT ZAFRACARLOS ALBERTO. APODERADO: MONTSERRAT ZAFRA CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 41036 , F 198, S 8, H B13337, I/A 26 (29.04.13).

28 de Octubre de 2011
Revocaciones. GERENTE: ORTOLL ZARAGOZA MARIA ROSARIO. APODERADO: ANDREU ALCACER JOSE MANUEL;ORTOLLJALBUENA CAROLINA. Datos registrales. T 41036 , F 197, S 8, H B 13337, I/A 25 (19.10.11).

20 de Junio de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: ORTOLL JALBUENA CAROLINA;GIMENEZ PASCUAL FRANCESC XAVIER;ORTOLL ZARAGOZAMARIA ROSARIO. CONS. DELEG.: ORTOLL JALBUENA CAROLINA M;GIMENEZ PASCUAL FRANCESC XAVIER. CONSEJERO:ORTOLL ZARAGOZA JORGE. PRESIDENTE: ORTOLL ZARAGOZA JORGE. VICEPRESIDEN: ORTOLL JALBUENA CAROLINA.SECRETARIO: GIMENEZ PASCUAL FRANCESC XAVIER. Nombramientos. ADM.UNICO: MONTSERRAT ZAFRA CARLOSALBERTO. Cambio de domicilio social. RD GENERAL MITRE Num.15 P.7 PTA.3 (BARCELONA). Datos registrales. T 41036 , F197, S 8, H B 13337, I/A 24 ( 8.06.11).

01 de Diciembre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: PARELLADA DE CARALT JOSE IGNACIO. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: IZUZQUIZA LEDO IORIOLS AUDITORS SLP. Datos registrales. T 41036 , F 196, S 8, H B 13337, I/A 23 (20.11.09).

04 de Marzo de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 166.651,29 Euros. Resultante Suscrito: 2.947.911,01 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 9: TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 27638 , F 42, S 8, H B 13337, I/A 22 (20.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n