Actos BORME de Andaluza De Gases Sa
26 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: FERRARA VINCENZO. Datos registrales. T 5250 , F 182, S 8, H SE 5142, I/A 82 (12.12.23).
25 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GIL DE DIEGO ANTONIO. Apo.Manc.: GIL DE DIEGO ANTONIO;CALDERON RIVILLAPILAR;GUTIERREZ SANCHEZ RAFAEL. Datos registrales. T 5250 , F 181, S 8, H SE 5142, I/A 81 (17.05.23).
25 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: MORALES SIERRA DIOGENES. Apo.Sol.: MORALES SIERRA DIOGENES. Otros conceptos: Se haceconstar expresamente que no se ha procedido a la revocación del poder otorgado en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, ante elNotario que fue de Madrid, don Ignacio de la Mora Leblanc, con el número 1.001 de protocolo.- Se hace constar expresamente que nose ha procedido a la revocación del poder otorgado en fecha diez de julio de dos mil dieciocho, ante el Notario que fue de Madrid, donIgnacio de la Mora Leblanc, con el número 1.279 de protocolo.- Datos registrales. T 5250 , F 181, S 8, H SE 5142, I/A 80 (18.04.23).
04 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: VINARDELL CORONA SANDRA. Datos registrales. T 5250 , F 181, S 8, H SE 5142, I/A 79(23.09.22).
03 de Junio de 2022Nombramientos. Auditor: VIDA BLANCA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 5250 , F 180, S
22 de Noviembre de 2021Reelecciones. Adm. Mancom.: S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.;NIPPON GASES ESPAÑA SL. Otros conceptos: S E deCarburos Metálicos SA, representante persona fisica don Miquel Lope Alonso y Nippon Gases España, SL, representante personafisica, don José Maria Revuelta Garcia. Datos registrales. T 5250 , F 180, S 8, H SE 5142, I/A 77 (15.11.21).
03 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER;GARCIA MORA AMAIA;RUBIO APARICIO FRANCISCOJAVIER;GARCIA MORA AMAIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ATAWNEH AMARAH AHMAD. Datos registrales. T 5250 , F 180,S 8, H SE 5142, I/A 76 (26.08.21).
25 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: CRUELLS PIÑOL JORDI. Otros conceptos: Se hace constar expresamente que no se ha practicadoinscripción de las revocaciones de los poderes a favor de DON JORDI CRUELLS PIÑOL en virtud de la escritura de poder otorgada enfecha veintiocho de enero de dos mil cuatro, ante el Notario que fue de Madrid, don Ignacio de la Mora Leblanc, con el. Datosregistrales. T 5250 , F 179, S 8, H SE 5142, I/A 75 (16.03.20).
25 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MORA AMAIA;RENAU GRANADOS MAR;BRACHI ALESSANDRA;GUIMARAES PEREIRALUCIANA Datos registrales. T 5250 , F 179, S 8, H SE 5142, I/A 74 (12.11.19).
11 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARREÑO MALLO CARMEN. Datos registrales. T 5250 , F 178, S 8, H SE 5142, I/A 72 ( 4.07.19).
Nombramientos. Apoderado: SAWA BORYSLAWSKA AGATA. Otros conceptos: REVOCA el poder no inscrito conferido a favorde Dona SOFIA ARMAN TURANO, y provista de N.I.F. n. 72.539.951-K, en virtud de Escritura de poder otorgada en fecha 2 denoviembre de 2017 ante el Notario de Madrid Don José María García Pedraza con el número 2.062 de su protocolo.- Datosregistrales. T 5250 , F 178, S 8, H SE 5142, I/A 73 ( 4.07.19).
04 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: VIDA BLANCA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 5250 , F 178, S 8,H SE 5142, I/A 71 (20.11.18).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO. Datos registrales. T 5250 , F 177, S 8, H SE 5142, I/A 70(16.11.18).
19 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: FADEUX KIM. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESCUER ZABALO GEMMA. Datos registrales. T5250 , F 176, S 8, H SE 5142, I/A 69 ( 7.06.18).
14 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GENICIO BORI JORDI;LUCKA MICHAL JOZEF;FADEUX KIM. Datos registrales. T 5250 , F 176, S8, H SE 5142, I/A 68 ( 7.02.18).
11 de Julio de 2017Otros conceptos: Se cesa por renuncia como representante persona física de la Sociedad "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROSMETALICOS, S.A.", administrador mancomunado de "ANDALUZA DE GASES, S.A.", a don José Luis Méndez López y se nombra ensu lugar a DON MIQUEL LOPE ALONSO.- Datos registrales. T 5250 , F 175, S 8, H SE 5142, I/A 67 (27.06.17).
18 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: NUÑEZ ALONSO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5250 , F 175, S 8, H SE 5142, I/A 66 ( 5.04.17).
11 de Abril de 2017Otros conceptos: Cambio de representante persona física del administrador mancomunado "Praxair España, S.L.", que será donJosé María Revuelta García. Datos registrales. T 5250 , F 175, S 8, H SE 5142, I/A 65 (23.03.17).
22 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: HUELIN TRILLO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5250 , F 174, S 8, H SE 5142, I/A 64(14.12.16).
12 de Septiembre de 2016Reelecciones. Adm. Mancom.: S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.;PRAXAIR ESPAÑA SL. Datos registrales. T 5250 , F 174, S8, H SE 5142, I/A 63 (30.08.16).
16 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: VIDA BLANCA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 5250 , F 173, S 8,H SE 5142, I/A 62 ( 8.03.16).
01 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: MORALES SIERRA DIOGENES;CALDERON REVILLA PILAR;GUTIERREZ SANCHEZ RAFAEL.Datos registrales. T 5250 , F 173, S 8, H SE 5142, I/A 61 (20.01.16).
17 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES SIERRA DIOGENES;MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO. Datos registrales. T 5250 , F172, S 8, H SE 5142, I/A 60 ( 9.07.15).
28 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: FELIPE RODRIGUEZ NAVARRO. Otros conceptos: REVOCADO el poder no inscrito otorgado a favorde DON FELIPE RODRIGUEZ NAVARRO, mediante, escritura otorgada en fecha ocho de octubre del año dos mil catorce, ante elNotario de Madrid, don Ignacio de la Mora Leblanc, número 1.001 de protocolo.- Datos registrales. T 5250 , F 172, S 8, H SE 5142,I/A 59 (20.05.15).
14 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: SIMON RIERA MARTIN;BENOIT DELAUME FABIEN;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJOSONIA;RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER;GARCIA MORA AMAIA;ROBERTZ MARKUS;LUENGO ZAMORANO JOSEVICENTE;FORNIELES RUEDA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 5250 , F 171, S 8, H SE 5142, I/A 58 (31.03.14).
21 de Marzo de 2014Reelecciones. Auditor: VIDA BLANCA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 5250 , F 171, S 8,H SE 5142, I/A 57 (10.03.14).
14 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: CRUELLS PIÑOL JORDI. Datos registrales. T 5250 , F 170, S 8, H SE 5142, I/A 56 ( 5.02.14).
16 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: SIMON RIERA MARTIN;CRUELLS PIÑOL JORDI;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJOSONIA;RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER;GARCIA MORA AMAIA;ROBERTZ MARKUS;LUENGO ZAMORANO JOSEVICENTE;FORNIELES RUEDA JOSE MANUEL. Apo.Sol.: CACHO MONTES FERNANDO;IRIARTE DOMINGUEZ CLARA;INSUELALORENZO SANTIAGO;ZULOAGA TRINCADO IÑIGO. Datos registrales. T 5250 , F 170, S 8, H SE 5142, I/A 55 ( 5.12.13).
09 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GOULA PFAFF LUIS. Apo.Man.Soli: LLOSENT DE NARDIZ MARIA DULCENOMBRE;CRUELLS PIÑOL JORDI;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA;RUBIO APARICIO FRANCISCOJAVIER;SIMON RIERA MARTIN;CRUELLS PIÑOL JORDI;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA. Apo.Sol.: LLOSENTDE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Apo.Man.Soli: RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5250 , F169, S 8, H SE 5142, I/A 54 (27.11.13).
13 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: COLE DE TEMPLE JOSE MANUEL. Apo.Sol.: COLE DE TEMPLE JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli:LOPEZ MANRIQUE ANGEL LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VINARDELL CORONA SANDRA;SIMON RIERAMARTIN;CRUELLS PIÑOL JORDI;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA;CARREÑO MALLO CARMEN;VINARDELLCORONA SANDRA. Apo.Sol.: CACHO MONTES FERNANDO;LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE;IRIARTEDOMINGUEZ CLARA. Apo.Man.Soli: RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5250 , F 166, S 8, H SE 5142, I/A53 ( 4.11.13).
25 de Marzo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA;LUENGO ZAMORANO JOSE VICENTE. Otrosconceptos: Las facultades 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 seránejercitadas MANCOMUNADAMENTE, con el límite económico de 1.800.000 Euros, y las facultades 6.1, 6.2 y 6.3, serán ejercitadasSOLIDARIAMENTE, y sin límite de cuantía.- Datos registrales. T 5250 , F 166, S 8, H SE 5142, I/A 52 ( 8.03.13).
26 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: OSADO ROBLEDO ADELAIDA;OSADO ROBLEDO ADELAIDA;OSADO ROBLEDO ADELAIDA.Datos registrales. T 5250 , F 166, S 8, H SE 5142, I/A 51 (14.09.12).
31 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUELLS PIÑOL JORDI;DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA;LOPEZ MANRIQUEANGEL LUIS;RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5250 , F 165, S 8, H SE 5142, I/A 50 (10.10.11).
14 de Septiembre de 2011Reelecciones. Adm. Mancom.: S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.;PRAXAIR ESPAÑA SL. Datos registrales. T 5250 , F 164, S8, H SE 5142, I/A 49 ( 1.09.11).
26 de Enero de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO;MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LLOSENT DE NARDIZ MARIA DULCE NOMBRE;OSADO ROBLEDO ADELAIDA;COLE DE TEMPLE JOSE MANUEL.Datos registrales. T 5250 , F 164, S 8, H SE 5142, I/A 48 (12.01.11).
28 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: VIDA BLANCA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA. Datos registrales. T 5250 , F 163, S8, H SE 5142, I/A 47 (15.12.10).
06 de Julio de 2010Revocaciones. Apoderado: BUSTAMANTE SERDIO JOSE ANTONIO;ELIAS PUIGBO JAVIER;PARDO YAÑEZ JUAN;STERLINGRODRIGUEZ F JAVIER;TOLEDO UGARTE GABRIEL;TOLEDO UGARTE GABRIEL;LLENAS CHAPARRO DANIEL. Apo.Man.Soli:BARDAJI AGUILERA ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: OSADO ROBLEDO ADELAIDA;MERLINO SANCHEZ ELVIRAROCIO;COLE DE TEMPLE JOSE MANUEL. Apo.Sol.: COLE DE TEMPLE JOSE MANUEL;NUÑEZ ALONSO MIGUEL ANGEL;SANSBLASCO MIREIA. Datos registrales. T 2424 , F 20, S 8, H SE 5142, I/A 46 (23.06.10).