Actos BORME de Andaluza De Morteros Sa
28 de Diciembre de 2022Reelecciones. Adm. Unico: SANDO MATERIALES Y SUMINISTROS SL. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 225, S 8, H MA22532, I/A 73 (16.12.22).
31 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 225, S 8, H MA 22532, I/A 72(23.08.22).
08 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: ALCARIAS VIZCAINO RAUL;BOLETO QUEIJA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5082, L3989, F 225, S 8, H MA 22532, I/A 71 (29.03.21).
30 de Noviembre de 2020Modificaci贸n de poderes. Apoderado: HOYO VILLACA脩AS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 224, S 8, H MA22532, I/A 70 (18.11.20).
26 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DE AURORA GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 224, S 8, H MA22532, I/A 69 (14.10.20).
02 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: ORTIZ RIVADO ELIAS. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 224, S 8, H MA 22532, I/A 68 (25.05.20).
01 de Febrero de 2018Reelecciones. Adm. Unico: SANDO MATERIALES Y SUMINISTROS SL. Cambio de objeto social. a) La fabricaci贸n y venta detodo tipo de hormigones y morteros y su distribuci贸n. b) La construcci贸n en general de viviendas de cualquier tipo. c) La construcci贸nde obras p煤blicas y cualquier obra de tipo civil. d) El desarrollo de urbanizaciones y movimientos de tierras. e) La realizaci贸n de proy.Datos registrales. T 5082, L 3989, F 223, S 8, H MA 22532, I/A 67 (24.01.18).
17 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: BELLIDO SOTO MARIA AUXILIADORA;ACEDO MIRANDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5082,L 3989, F 223, S 8, H MA 22532, I/A 66 ( 2.08.17).
03 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: VARONA FIDALGO DIEGO. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 223, S 8, H MA 22532, I/A 65(21.03.17).
27 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 223, S 8, H MA 22532, I/A 64 (18.12.13).
23 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SANCHEZ MANZANO LUIS;SANCHEZ MANZANO ESTHER. Nombramientos. Adm. Unico:SANDO MATERIALES Y SUMINISTROS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico.Administraci贸n y Representacion.-.Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 5082, L3989, F 222, S 8, H MA 22532, I/A 63 (13.08.13).
21 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 222, S 8, H MA 22532, I/A 61(11.03.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS;SANCHEZ MANZANO ESTHER;RUZ RAMOS JESUS;CRESPOSOLIS ANGEL;FLORES ALES JOSE MARIA. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 222, S 8, H MA 22532, I/A 62 (11.03.13).
09 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532, I/A 59 (27.12.12).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: SANCHEZ MANZANOESTHER. Reelecciones. Adm. Solid.: SANCHEZ MANZANO LUIS. Datos registrales. T 5082, L 3989, F 222, S 8, H MA 22532, I/A60 (27.12.12).
12 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: BOZA GONZALEZ MANUEL C. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532, I/A 58(29.11.12).
02 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GALAN GARCIA-ROJO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532,I/A 57 ( 9.10.12).
19 de Junio de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: VILLODRES PADILLA JOSE. Apoderado: VILLODRES PADILLA JOSE. Apo.Manc.: VILLODRESPADILLA JOSE. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532, I/A 56 ( 5.06.12).
03 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: VARONA FIDALGO DIEGO. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532, I/A 54(13.04.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: VARONA FIDALGO DIEGO;SANCHEZ MANZANO ESTHER;RUZ RAMOS JESUS;CRESPO SOLISANGEL;FLORES ALES JOSE MARIA. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 104, S 8, H MA 22532, I/A 55 (13.04.12).
23 de Febrero de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 53 ( 9.02.12).
30 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ PRADOS FEDERICO. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 52(15.11.11).
28 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 51 (16.03.11).
25 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: PILO GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 50(12.11.10).
15 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 49 ( 2.02.10).
24 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4449, L 3358, F 103, S 8, H MA 22532, I/A 48 (11.03.09).