Actos BORME de Andel Madrid Automocion Sa
07 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 32367 , F 140, S 8, H M 582654, I/A 14 (29.11.23).
11 de Junio de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 335.500,00 Euros. Desembolsado: 93.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.570.200,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.327.950,00 Euros. Datos registrales. T 32367 , F 139, S 8, H M 582654, I/A 13 ( 5.06.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 32367 , F 138, S 8, H M 582654, I/A 12 ( 6.05.21).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ ALGABA FRANCISCO;SANZ ARROYO CARLOS;GARCIA DE LA TORRE PONCEPEDRO;JIMENEZ CANO RUBEN;GARCIA CARMONA JOSE;SOSA LAMA RAFAEL;JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE. Presidente:MARQUEZ ALGABA FRANCISCO. Vicepresid.: SANZ ARROYO CARLOS. Secretario: GARCIA DE LA TORRE PONCE PEDRO.Vicesecret.: JIMENEZ CANO RUBEN. Cons.Del.Man: JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE. Consejero: ARRIBAS MEJIAS MARIANO.Cons.Del.Man: SANZ ARROYO CARLOS. Revocaciones. Apoderado: GARCIA COFRADES MIGUEL. Nombramientos.Consejero: MARQUEZ ALGABA FRANCISCO;SANZ ARROYO CARLOS;MARTINEZ SEPULVEDA JOSE RAMON;JIMENEZ CANORUBEN;JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE;SOSA LAMA RAFAEL;GARCIA CARMONA JOSE;MURIAS SACRISTAN JUAN JOSE.Presidente: MARQUEZ ALGABA FRANCISCO. Secretario: MARTINEZ SEPULVEDA JOSE RAMON. Vicepresid.: SANZ ARROYOCARLOS. Vicesecret.: JIMENEZ CANO RUBEN. Cons.Del.Man: JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE;SANZ ARROYO CARLOS. Datosregistrales. T 32367 , F 138, S 8, H M 582654, I/A 11 (12.04.19).
05 de Septiembre de 2018Modificaciones estatutarias. 14. Datos registrales. T 32367 , F 137, S 8, H M 582654, I/A 10 (29.08.18).
23 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 32367 , F 137, S 8, H M 582654, I/A 9 (15.01.18).
19 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 264.700,00 Euros. Desembolsado: 264.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.234.700,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.234.700,00 Euros. Datos registrales. T 32367 , F 136, S 8, H M 582654, I/A 8 (11.05.17).
29 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: VARELA LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32367 , F 136, S 8, H M 582654, I/A 7 (20.06.16).
10 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: VARELA LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32367 , F 135, S 8, H M 582654, I/A 6 ( 1.12.15).
07 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COFRADES MIGUEL. Cons.Del.Man: GARCIA COFRADES MIGUEL. Nombramientos.Consejero: ARRIBAS MEJIAS MARIANO. Cons.Del.Man: SANZ ARROYO CARLOS. Datos registrales. T 32367 , F 135, S 8, H M582654, I/A 5 (26.11.15).
06 de Febrero de 2015Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 460.000,00 Euros. Datos registrales. T 32367 , F 134, S 8, H M 582654, I/A 4(29.01.15).
16 de Julio de 2014Cambio de domicilio social. C/ ARTES GRAFICAS 9 - P.I. LAS ARENAS DE PINTO (PINTO). Datos registrales. T 32367 , F 134,S 8, H M 582654, I/A 3 ( 7.07.14).
18 de Junio de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.04.14. Objeto social: La compra, venta, importaci贸n, exportaci贸n, almacenamiento,distribuci贸n y suministro de toda clase de art铆culos de recambio, accesorios, aceites, lubricantes, neum谩ticos, componenteselectr贸nicos, prendas y objetos deportivos, maquinaria, herramientas y utillaje... Domicilio: PASEO DE LA CHOPERA - N潞 129- 4潞 C(ALCOBENDAS). Capital suscrito: 970.000,00 Euros. Desembolsado: 510.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MARQUEZALGABA FRANCISCO;SANZ ARROYO CARLOS;GARCIA DE LA TORRE PONCE PEDRO;JIMENEZ CANO RUBEN;GARCIACARMONA JOSE;SOSA LAMA RAFAEL;JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE;GARCIA COFRADES MIGUEL. Presidente: MARQUEZALGABA FRANCISCO. Vicepresid.: SANZ ARROYO CARLOS. Secretario: GARCIA DE LA TORRE PONCE PEDRO. Vicesecret.:JIMENEZ CANO RUBEN. Cons.Del.Man: JUNQUERA SUAREZ ENRIQUE;GARCIA COFRADES MIGUEL. Datos registrales. T32367 , F 130, S 8, H M 582654, I/A 1 (10.06.14).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA COFRADES MIGUEL. Datos registrales. T 32367 , F 133, S 8, H M 582654, I/A 2 (11.06.14).