Actos BORME de Anfix Software Sl
29 de Marzo de 2023Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO 377 - 7 D (MADRID). Datos registrales. T 42567 , F 12, S 8, H M 718242, I/A 12(22.03.23).
01 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: ANDRADE CASTILLO ERICK ALEXANDER. Apoderado: NAVAS VINAGRE ISABEL DEL SAGRARIO.Apo.Man.Soli: ANDRADE CASTILLO ERICK ALEXANDER. Apo.Manc.: REDONDO SANCHEZ FERNANDO;ANDRADE CASTILLOERICK ALEXANDER;MENDOZA EVAGGELOU MAIKEL ANDRES. Nombramientos. Apo.Sol.: LARA SACIDO MONICA LOURDES.Apo.Manc.: LARA SACIDO MONICA LOURDES;REDONDO SANCHEZ FERNANDO;MENDOZA EVAGGELOU MAIKEL ANDRES.Datos registrales. T 42567 , F 10, S 8, H M 718242, I/A 11 (24.11.22).
20 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: DE VALDES DU脩ABEITIA LUIS;REDONDO SANCHEZ FERNANDO;ANDRADE CASTILLO ERICKALEXANDER;DE VALDES DU脩ABEITIA LUIS. Nombramientos. Apoderado: MENDOZA EVAGGELOU MAIKEL ANDRES.Apo.Manc.: REDONDO SANCHEZ FERNANDO;ANDRADE CASTILLO ERICK ALEXANDER;MENDOZA EVAGGELOU MAIKELANDRES. Otros conceptos: Revocado el poder mancomunado conferido a Erik Alexander Andrade Castillo otorgado el 24 deseptiembre de 2021 ante el notario de Madrid Angel Almoguera G贸mez con n煤mero 4.794 de protocolo, inscripci贸n 6潞. Datosregistrales. T 42567 , F 7, S 8, H M 718242, I/A 10 (13.09.22).
27 de Junio de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 242.347,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.027.328,20 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:30.381,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.057.710,00 Euros. Datos registrales. T 42567 , F 5, S 8, H M 718242, I/A 9 (20.06.22).
24 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE. Apoderado: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE. Apo.Manc.:DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO SANCHEZ FERNANDO. Apo.Manc.: REDONDOSANCHEZ FERNANDO;ANDRADE CASTILLO ERICK ALEXANDER;DE VALDES DU脩ABEITIA LUIS. Datos registrales. T 42567 , F3, S 8, H M 718242, I/A 8 (18.06.22).
08 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE. Secretario: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE.Nombramientos. Consejero: REDONDO SANCHEZ FERNANDO. Secretario: REDONDO SANCHEZ FERNANDO. Datosregistrales. T 42567 , F 3, S 8, H M 718242, I/A 7 ( 1.03.22).
26 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Apo.Manc.: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA;DE SANTOSARRANZ CAROLINA;DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE;DE SANTOS ARRANZ CAROLINA;GOMEZ-ACEBO GASSET JUAN.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANDRADE CASTILLO ERICK ALEXANDER. Apo.Manc.: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE;DEVALDES DU脩ABEITIA LUIS. Datos registrales. T 40445 , F 114, S 8, H M 718242, I/A 6 (19.10.21).
20 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE. Apo.Manc.: DE LA MORA GONZALEZ JUAN JOSE;DESANTOS ARRANZ CAROLINA;GOMEZ-ACEBO GASSET JUAN.Apoderado: NAVAS VINAGRE ISABEL DEL SAGRARIO. Datosregistrales. T 40445 , F 112, S 8, H M 718242, I/A 5 (13.09.21).
17 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN;ARCELUS IROZ MIGUEL JOSE. Vicepresid.: SACIDO MARTINANTONIO. Secretario: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN. Presidente: ARCELUS IROZ MIGUEL JOSE. Revocaciones. Apo.Sol.:GOMEZ ACEBO GASSET JUAN. Apo.Manc.: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN. Nombramientos. Consejero: DE LA MORAGONZALEZ JUAN JOSE;BLANCO IGLESIAS ESTANISLAO JOSE. Presidente: SACIDO MARTIN ANTONIO. Secretario: DE LAMORA GONZALEZ JUAN JOSE. Vicepresid.: BLANCO IGLESIAS ESTANISLAO JOSE. Apo.Manc.: ANDRADE CASTILLO ERICK
10 de Julio de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 83.018,40 Euros. Resultante Suscrito: 784.980,40 Euros. Datos registrales. T 40445 , F 108, S 8, H
12 de Mayo de 2020Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO NUMERO 377, 7潞 B (MADRID). Datos registrales. T 40445 , F 108, S 8, H M718242, I/A 2 ( 4.05.20).
17 de Abril de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 234.031,60 Euros. Resultante Suscrito: 701.962,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 12.Lugarde celebraci贸n. 1.- La junta General se celebrar谩 en el t茅rmino municipal donde la Sociedad tenga su domicilio social, Si en laconvocatoria no figurase el lugar de celebraci贸n, se entender谩 que la Junta ha sido convocada para su celebraci贸n en el domiciliosocial. 2.- Ser谩n v谩lidas los 14. Asistencia y representaci贸n.- 1.- Podr谩n asistir a la Junta General los titulares de participacionessociales que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Socios o que hubieren comunicado a la Sociedad su adquisici贸n antes de lacelebraci贸n de la reuni贸n. 2.- Los socios podr谩n hacerse 26. Convocatoria del Consejo de Administraci贸n.- 1.- El Consejo deAdministraci贸n ser谩 convocado por el Presidente, o en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de 茅ste, por elVicepresidente, siempre que lo consideren necesario o conveniente. 2.- En cualquier caso, el Consejo. Datos registrales. T 1570 , F77, S 8, H VA 23198, I/A 13 ( 8.04.20).
20 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA;PASCUAL SANCHO JORGE. Secretario: DE SANTOS ARRANZCAROLINA. Presidente: PASCUAL SANCHO JORGE. Con.Delegado: PASCUAL SANCHO JORGE. Nombramientos. Auditor: UHYFAY AND CO AUDITORES CONSULTORES SL. Consejero: ARCELUS IROZ MIGUEL JOSE;GOMEZ ACEBO GASSET JUAN.Presidente: ARCELUS IROZ MIGUEL JOSE. Vicepresid.: SACIDO MARTIN ANTONIO. Secretario: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN.Datos registrales. T 1380 , F 74, S 8, H VA 23198, I/A 11 (13.02.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN. Apo.Manc.: GOMEZ ACEBO GASSET JUAN;DE SANTOS ARRANZCAROLINA. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Datos registrales. T 1380 , F 75, S 8, H VA23198, I/A 12 (13.02.20).
06 de Junio de 2018Nombramientos. Auditor: UHY FAY AND CO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1380 , F 74, S 8, H VA 23198,I/A 10 (30.05.18).
28 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 119.521,00 Euros. Resultante Suscrito: 436.860,40 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:31.070,00 Euros. Resultante Suscrito: 467.930,40 Euros. Datos registrales. T 1380 , F 74, S 8, H VA 23198, I/A 9 (20.12.17).
27 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 74.960,00 Euros. Resultante Suscrito: 146.388,60 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:170.950,80 Euros. Resultante Suscrito: 317.339,40 Euros. Datos registrales. T 1380 , F 42, S 8, H VA 23198, I/A 8 (20.01.17).
16 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 21.428,60 Euros. Resultante Suscrito: 71.428,60 Euros. Datos registrales. T 1380 , F 41, S 8, H VA23198, I/A 7 ( 9.01.15).
21 de Julio de 2014Cambio de domicilio social. PLAZA ESPA脩A 13 3& (VALLADOLID). Datos registrales. T 1380 , F 41, S 8, H VA 23198, I/A 6(14.07.14).
14 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO. Secretario: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO.Nombramientos. Consejero: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Secretario: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Datos registrales.T 1380 , F 41, S 8, H VA 23198, I/A 5 ( 7.10.13).
23 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Presidente: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO. Secretario:DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Con.Delegado: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO. Nombramientos. Consejero:PASCUAL SANCHO JORGE. Presidente: PASCUAL SANCHO JORGE. Secretario: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO.Con.Delegado: PASCUAL SANCHO JORGE. Cambio de domicilio social. C/ ACERA DE RECOLETOS 2 1潞 B (VALLADOLID).Datos registrales. T 1380 , F 41, S 8, H VA 23198, I/A 4 (14.08.12).
30 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA. Datos registrales. T 1380 , F 40, S 8, H VA 23198, I/A 3(21.05.12).
29 de Junio de 2010Nombramientos. Presidente: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO. Secretario: DE SANTOS ARRANZ CAROLINA.Con.Delegado: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO. Datos registrales. T 1380 , F 40, S 8, H VA 23198, I/A 2 (18.06.10).
09 de Junio de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.05.10. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto el desarrollo y venta de cualquier tipode soluci贸n inform谩tica tanto software como hardware, incluyendo aqu茅llas basadas en nuevas tecnolog铆as, as铆 como la prestaci贸n delos servicios de operaci贸n y mantenimiento. Etc. Domicilio: C/ ANDRES LAGUNA 9-11 - PARQUE TECNOLOGICO DE BOEC(BOECILLO). Capital: 50.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GAYUBO DOMINGUEZ LUIS CARMELO;DE SANTOSARRANZ CAROLINA;SACIDO MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 1380 , F 36, S 8, H VA 23198, I/A 1 (31.05.10).