Actos BORME de Anicura Alhaurin Hospital Veterinario Sl
06 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ANICURA SPAIN HOLDING SL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ SANZ JESUSALBERTO;GRIP OSKAR NIKOLAUS;REAL MARTINEZ VERONICA. Apo.Manc.: LUIS MASI JOSE;GOMEZ GARCIA JOSE;REALMARTINEZ VERONICA;GRIP OSKAR NIKOLAUS;PEREZ SANZ JESUS ALBERTO. Apo.Man.Soli: LOPEZ FERNANDEZ JESUSMARIA;MORENO BOISO ANTONIO-ANGEL;GARAGORRI DIEZ ESTIBALIZ. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T45214 , F 198, S 8, H M 795603, I/A 3 (27.10.23).
21 de Junio de 2023Cambio de domicilio social. C/ NU脩EZ DE BALBOA 88 1潞 D (MADRID). Datos registrales. T 45214 , F 198, S 8, H M 795603, I/A 2(14.06.23).
14 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARAGORRI DIEZ ESTIBALIZ. Datos registrales. T 6190, L 5097, F 148, S 8, H MA 56515, I/A 12 (3.02.23).
14 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: CARDONA GARCIA ENRIQUE;LOPEZ FERNANDEZ JESUS MARIA;POLO MARTIN ALVARO. Datosregistrales. T 6190, L 5097, F 148, S 8, H MA 56515, I/A 11 ( 5.12.22).
11 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO BOISO ANTONIO-ANGEL;LOPEZ FERNANDEZ JESUS MARIA. Apo.Manc.: PEREZSANZ JESUS ALBERTO;GRIP OSKAR NIKOLAUS;REAL MARTINEZ VERONICA;GOMEZ GARCIA JOSE;LUIS MASI JOSE. Datosregistrales. T 6190, L 5097, F 147, S 8, H MA 56515, I/A 10 ( 3.10.22).
01 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ SANZ JESUS ALBERTO;GRIP OSKAR NIKOLAUS;REAL MARTINEZ VERONICA. Datosregistrales. T 6190, L 5097, F 146, S 8, H MA 56515, I/A 9 (21.07.22).