Actos BORME de Antevenio Rich & Reach Sl
23 de Diciembre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 39814 , F 167, S 8, H M 561111, I/A 18 (16.12.21).
17 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ APOLONIO MORALES 13 C (MADRID). Datos registrales. T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A15 (10.03.21).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ HIDALGO JESUS;BOUCHET CHARLOTTE;BLANCH MARTIN RUTH. Apo.Sol.: PEREZHIDALGO JESUS. Apoderado: PEREZ GARCIA DELIA;USTRELL RIVERA JORDI. Nombramientos. Apoderado: USTRELL RIVERAJORDI;BLANCH MARTIN RUTH-MARIA;CALVO RODRIGUEZ RUBEN;NAZ VILLALBA BELEN;PEREZ HIDALGO JESUS;VAZQUEZZUBELDIA GONZALO;RODES MIRACLE JUAN;GARCIA NOBLIA ANALORE. Datos registrales. T 39814 , F 162, S 8, H M 561111,I/A 16 (10.03.21).
Nombramientos. Apoderado: USTRELL RIVERA JORDI;BLANCH MARTIN RUTH-MARIA;BOUCHET CHARLOTTE;PEREZ GARCIADELIA;ORTU脩O SERRANO BEATRIZ;PEREZ HIDALGO JESUS;VAZQUEZ ZUBELDIA GONZALO;RODES MIRACLE JUAN. Datos
22 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: GRA脩A MORAN DAVID. Datos registrales. T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A 14 (15.01.20).
21 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA DELIA. Datos registrales. T 39814 , F 160, S 8, H M 561111, I/A 12 (14.01.20).
Nombramientos. Apoderado: USTRELL RIVERA JORDI. Datos registrales. T 39814 , F 161, S 8, H M 561111, I/A 13 (14.01.20).
14 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ HIDALGO JESUS. Datos registrales. T 39814 , F 160, S 8, H M 561111, I/A 11 ( 7.01.20).
20 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: BLANCH MARTIN RUTH. Datos registrales. T 31176 , F 185, S 8, H M 561111, I/A 10 (13.12.19).
19 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: PEREZ GARCIA VILLOSLADA PABLO;SANCHEZ GARATE FERNANDO. Datos registrales. T 31176 ,F 184, S 8, H M 561111, I/A 7 (12.12.19).
Nombramientos. Apoderado: BOUCHET CHARLOTTE. Datos registrales. T 31176 , F 184, S 8, H M 561111, I/A 8 (12.12.19).
Nombramientos. Apoderado: GRA脩A MORAN DAVID. Datos registrales. T 31176 , F 185, S 8, H M 561111, I/A 9 (12.12.19).
17 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ GARCIA-VILLOSLADA PABLO. Nombramientos. Representan: MONGE RODRIGUEZANDREA. Datos registrales. T 31176 , F 184, S 8, H M 561111, I/A 6 (10.12.19).
24 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GARATE FERNANDO. Datos registrales. T 31176 , F 182, S 8, H M 561111, I/A 5(17.06.19).
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: NOVICK JOSHUA DAVID. Nombramientos. Representan: PEREZ GARCIA-VILLOSLADAPABLO. Datos registrales. T 31176 , F 182, S 8, H M 561111, I/A 4 (10.01.19).
29 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: PEREZ HIDALGO JESUS. Datos registrales. T 31176 , F 181, S 8, H M 561111, I/A 2 (21.10.13).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA VILLOSLADA PABLO. Datos registrales. T 31176 , F 181, S 8, H M 561111, I/A 3(21.10.13).
01 de Julio de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.06.13. Objeto social: "La prestaci贸n de servicios de Internet, especialmente en el 谩mbitode la publicidad online. Realizaci贸n de aquellas actividades que, seg煤n las disposiciones vigentes en materia de publicidad, sonpropias de las Agencias de Publicidad y Medios de Difusi贸n, pudiendo realizar todo g茅nero de actos, con. Domicilio: C/ MARQUES DERISCAL 11, - 2 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ANTEVENIO SA.Nombramientos. Representan: NOVICK JOSHUA DAVID. Adm. Unico: ANTEVENIO SA. Datos registrales. T 31176 , F 179, S 8, HM 561111, I/A 1 (21.06.13).