Buscador CIF Logo

Actos BORME Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa

Actos BORME Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa - A12802872

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Castellon para Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa con CIF A12802872

馃敊 Perfil de Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Castellon

Actos BORME de Aparcamiento Avda Europa Pozuelo Sa

23 de Octubre de 2012
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1593, L 1155, F 120, S 8, H CS 34282, I/A 3 ( 5.10.12).

08 de Junio de 2012
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el art铆culo 4潞 de los Estatutos. Cambio de domicilio social. C/GRECIA 31 - POLIGONO CIUDAD DEL TRANSPORTE II (CASTELLON DE LA PLANA). Datos registrales. T 1593, L 1155, F 120, S8, H CS 34282, I/A 2 (30.05.12).

09 de Enero de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 965.325,00 Euros. Resultante Suscrito: 321.775,00 Euros. Datos registrales. T 26194 , F206, S 8, H M 467366, I/A 9 (28.12.11).

16 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUBASA CONCESIONES SLU;ARENAS DE LEVANTE SLU. Presidente: ARENAS DE LEVANTESLU. Representan: BEOTEGUI ZUBIETA IGNACIO;OLLER SANZ JUAN ALBERTO. Nombramientos. Representan: OLLER SANZJUAN ALBERTO;BEOTEGUI ZUBIETA IGNACIO. Consejero: URBANIZADORA LA COVA SL;ARIDOS EL JUNCAR SL. Presidente:URBANIZADORA LA COVA SL. Datos registrales. T 26194 , F 205, S 8, H M 467366, I/A 8 (30.08.11).

19 de Febrero de 2010
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 6 OTROS ACTOS INSCRIBIBLES SIENDO EL TEXTOCORRECTO "DON ANTONIO JOSE MARCO MU脩OZ, HA RENUNCIADO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTEESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION SEGUNDA.". Datos registrales. T 26194 , F 205, S 8, H M 467366, I/A 6 (28.01.10).

16 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDREU MOLINER FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26194 , F 205, S 8, H M 467366, I/A7 ( 4.02.10).

10 de Febrero de 2010
Otros conceptos: DON MANUEL GINER MARTI, HA RENUNCIADO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTEESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION SEGUNDA. Datos registrales. T 26194 , F 205, S 8, H M 467366, I/A 6 (28.01.10).

23 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ CASADO FAUSTO. Presidente: GONZALEZ CASADO FAUSTO. Consejero:RODRIGUEZ GARCIA RAMON;LUBASA APARCAMIENTOS SLU. Con.Delegado: LUBASA APARCAMIENTOS SLU. Representan:GASCON BRINES FRANCISCO VICENTE. Nombramientos. Representan: BEOTEGUI ZUBIETA IGNACIO;GASCON BRINESFRANCISCO VICENTE. Consejero: LUBASA CONCESIONES SLU;LUBASA APARCAMIENTOS SLU;ARENAS DE LEVANTE SLU.Presidente: ARENAS DE LEVANTE SLU. Con.Delegado: LUBASA APARCAMIENTOS SLU. Representan: OLLER SANZ JUAN

22 de Septiembre de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ CASADO FAUSTO. Datos registrales. T 26194 , F 204, S 8, H M 467366, I/A 4(10.09.09).

24 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: AREOSA SASTRE MANUEL. Datos registrales. T 25930 , F 204, S 8, H M 467366, I/A 3 (12.02.09).

12 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ SAFONT ARCADIO;OLLER SANZ JUAN ALBERTO;GINER MARTI MANUEL;SANCHEZDEL RIO BARRIOS LUIS;MARCO MU脩OZ ANTONIO JOSE;AREOSA SASTRE MANUEL;MARTINEZ TENA

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n