Buscador CIF Logo

Actos BORME Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl

Actos BORME Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl - B85484475

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl con CIF B85484475

馃敊 Perfil de Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aparcamientos Ic Gomez Ulla Sl

01 de Julio de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 784/2019. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/06/2022. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: CONCURSO VOLUNTARIO ORDINARIO: ANOTACION PREVENTIVA del AUTO de APERTURA de la FASE deCONVENIO. Datos registrales. T 27613 , F 161, S 8, H M 465572, I/A B (24.06.22).

30 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;CABALLERO FERNANDEZFERNANDO;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSE DEMETRIO;MORENO ALVAREZ LUIS;PIJOANMARIN ESTEBAN;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;SENDARRUBIAS REDONDO JOSE MARIA;GARCIA ZARANDIETAGIMENEZ ANTONIO JUAN;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLOANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apo.Sol.: MARTIN CASTELLO FELIX;GONZALEZ DURAN BARBARA;FOJO ARIASLINO;HERNANDEZ NU脩EZ ANTONIO;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;CALVO REYMANUEL;MARTINEZ LARRAD DANIEL EUSEBIO;ORTIZ DE LA TABLA GONZALEZ JOSE;CODES DIAZ QUETCUTI

24 de Noviembre de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 784/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 10/07/2020. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: SE ESTIMA LA SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL MEDIANTE ESCRITO DE FECHA.22-11-2919, YSE MODIFICA EL REGIMEN DE INTERVENCION EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL DEUDOR, QUE PASA A SER ELDE SUSPENSION DE DICHAS FACULTADES, QUEDANDO SUSTITUIDO POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL.- Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 784/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 10/07/2020. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 27613 , F 160, S 8, H M 465572, I/A 22 (17.11.20).

29 de Enero de 2020
Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 784/2019. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 11/04/2019. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: La deudora conservar谩 las facultades de administraci贸n ydisposici贸n sobre su patrimonio quedando sometido el ejercicio de 茅stas a la intervenci贸n de la administraci贸n concursal. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 784/2019. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/04/2019. Resoluciones acordando la intervenci贸no suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 784/2019. Fecha deresoluci贸n 11/04/2019. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID.Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 11/04/2019, NIF/CIF B65793879. DATA CONCURSAL SLP.Datos registrales. T 27613 , F 159, S 8, H M 465572, I/A A (22.01.20).

29 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO. Datos registrales. T 27613 , F 159, S 8, H M 465572, I/A 21(22.05.19).

19 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO. Apoderado: DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO. Datosregistrales. T 27613 , F 159, S 8, H M 465572, I/A 20 (11.04.18).

10 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS SOUTO VICENTE ABELARDO. Datos registrales. T 27613 , F 159, S 8, H M 465572, I/A 19(27.10.16).

27 de Abril de 2016
Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS SOUTO VICENTE ABELARDO. Datos registrales. T 27613 , F 155, S 8, H M 465572, I/A17 (19.04.16).

Nombramientos. Apoderado: DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO. Datos registrales. T 27613 , F 158, S 8, H M 465572, I/A 18(19.04.16).

29 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO. Datos registrales. T27613 , F 154, S 8, H M 465572, I/A 15 (18.06.15).

Revocaciones. Apoderado: DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T 27613, F 155, S 8, H M 465572, I/A 16 (18.06.15).

28 de Abril de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 222.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 228.440,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 5潞. Capital.-. Datos registrales. T 27613 , F 153, S 8, H M 465572, I/A 14 (16.04.14).

25 de Marzo de 2014
Modificaciones estatutarias. 7. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 27613 , F 153, S 8, H M 465572,I/A 13 (17.03.14).

07 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: BELATEGUI AZPIRI I脩AKI. Datos registrales. T 27613 , F 151, S 8, H M 465572, I/A 12 (31.05.13).

07 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: DOLDAN VAZQUEZ JUAN LORENZO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T27613 , F 150, S 8, H M 465572, I/A 11 (11.08.11).

13 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos.Adm. Unico: DIAZ-RINCON COTELO ROBERTO MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 27613 , F 150, S 8, H M 465572, I/A 10 (29.11.10).

31 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOSMANUEL-JOSE;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 25834 , F 218, S 8, H M 465572, I/A 9 (19.08.10).

21 de Julio de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIA OZALLA OSCAR. Datos registrales. T 25834 , F 217, S 8, H M 465572, I/A 7 (12.07.10).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MESEGUER VELASCO JOSE LUIS;RENGIFO ABBAD ALVARO. Datos registrales. T 25834 , F 218,S 8, H M 465572, I/A 8 (12.07.10).

18 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Datos registrales. T 25834 , F69, S 8, H M 465572, I/A 5 ( 4.12.09).

Nombramientos. Apoderado: SALMERON UNTURBE JESUS;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUELJOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 25834 , F 216, S 8, H M 465572, I/A6 ( 4.12.09).

02 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DAPENA FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 25834 , F 69, S 8, H M 465572, I/A 4(21.01.09).

12 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA MARCO JUAN;ZAMORANO LEYVA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 25834 , F 69, S 8, HM 465572, I/A 3 (24.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n