Buscador CIF Logo

Actos BORME Aparcamientos Islas Canarias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aparcamientos Islas Canarias Sl

Actos BORME Aparcamientos Islas Canarias Sl - B35883727

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aparcamientos Islas Canarias Sl con CIF B35883727

馃敊 Perfil de Aparcamientos Islas Canarias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aparcamientos Islas Canarias Sl

10 de Noviembre de 2023
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 15/09/2023. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se aprueba la propuesta de convenio de la concursada. Datos registrales. T 33441 , F 40, S 8, H M 552064, I/A C (2.11.23).

29 de Marzo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ GENOVA, NUMERO 15, 1潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33441 , F 40, S 8, H M552064, I/A 24 (22.03.23).

04 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 33441 , F 38, S 8, H M 552064, I/A 23(27.10.22).

29 de Julio de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/06/2022. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se declara finalizada la fase com煤n del procedimiento concursal. Se abre la fase de convenio, form谩ndose la secci贸nquinta. Datos registrales. T 33441 , F 38, S 8, H M 552064, I/A B (21.07.22).

01 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;GRACIACEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE DEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apo.Manc.: VERA MARTINEZRAUL;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;GARRIDO ESPA MIGUEL. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;BUSCAMARTIN SANZ ALVARO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;VIEJO GONZALEZ DOLORES;VERA MARTINEZ RAULENRIQUE;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;GARRIDO ESPA MIGUEL;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUANCARLOS;RODRIGUEZ DORADO GONZALO;MEDIANO LORENCI YOLANDA;CHAVES DECLARA JESUS;LOPEZ PEREZROBERTO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIAMARIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;ESPARZA TORRECILLA JESUS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;DE LAS CASASGONZALEZ LUIS;BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;RODRIGUEZ DORADO GONZALO. Datosregistrales. T 33441 , F 38, S 8, H M 552064, I/A 22 (25.05.22).

03 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ DIAZ SANDRA MARIA;LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;NAVAS-PAREJO MENDEZ EMILIO. Datos registrales. T 33441 , F 37, S 8, H M 552064, I/A 21 (27.05.21).

30 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN. Datosregistrales. T 33441 , F 37, S 8, H M 552064, I/A 20 (23.11.20).

29 de Octubre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ CRISTOBAL BORDIU NUMERO 35-ENTREPLANTA, LOCAL 1 (MADRID). Datos registrales. T33441 , F 36, S 8, H M 552064, I/A 19 (22.10.20).

12 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: VERA VAZQUEZ FRANCISCO.Modificaciones estatutarias. 22. Datos registrales. T 33441 , F 36, S 8, H M 552064, I/A 18 ( 5.08.20).

27 de Enero de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Se declara la firmeza del auto de 29 de mayo de 2018 por el que se anot贸 la declaraci贸n de concurso de acreedores,nombramiento de administrador concursal. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n29/05/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se acumula el concurso al procedimiento 700/2017 del mismo juzgadocorrespondiente a la sociedad Grupo Isolux Corsan SA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fechade resoluci贸n 29/05/2018. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datosregistrales. T 33441 , F 36, S 8, H M 552064, I/A 17 (16.01.20).

31 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 33441 , F 36, S 8, H M552064, I/A 16 (24.05.19).

03 de Enero de 2019
Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 33441 , F 35, S 8, H M 552064, I/A 15(21.12.18).

16 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: REINA PINTO JUAN CARLOS;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Nombramientos. Adm. Unico:REINA PINTO JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 33441 , F 35, S 8, H M 552064, I/A 14 ( 7.11.18).

29 de Junio de 2018
Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se declara en concurso de acreedores de car谩cter voluntario. Eldeudor conserva.las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio. Se acuerda la acumulaci贸n de los anterioresconcursos al que se tramita bajo los autos de concurso n煤mero 700/2017, para su tramitaci贸n coordinada bajo. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 779/2018. Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 29/05/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Datos registrales. T 33441 , F 35, S 8, H M 552064, I/A A (20.06.18).

26 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: ESPARZA TORRECILLA JESUS;AVILA ALVAREZ FEDERICO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;DE LAS CASASGONZALEZ LUIS;BUSCA MARTIN-SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;RODRIGUEZ DORADO GONZALO. Datosregistrales. T 33441 , F 29, S 8, H M 552064, I/A 13 (15.12.17).

27 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 33441 , F 29, S 8, H M 552064, I/A 12 (20.10.17).

10 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;LIMONHOSTENCH JAIME;RODRIGUEZ DORADO GONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;MEDIANO LORENCI YOLANDA;CHAVESDECLARA JESUS;LOPEZ PEREZ ROBERTO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZCRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIA MARIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 33441 , F 24, S 8, H M552064, I/A 11 (29.04.16).

26 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PIRE ABARCA FERNANDO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 30679 , F 160, S 8, H M 552064, I/A9 (19.05.15).

Nombramientos. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;VIEJO GONZALEZ DOLORES;VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE;HERNANDEZ MU脩OZANTONIO JESUS;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datos registrales. T 30679 , F 161, S 8, H M 552064, I/A 10 (19.05.15).

31 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: VERA MARTINEZ RAUL;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datosregistrales. T 30679 , F 160, S 8, H M 552064, I/A 8 (24.03.15).

10 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Datos registrales. T 30679 , F 160, S 8, H M 552064, I/A 7(26.02.15).

22 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL. Datos registrales. T 30679 , F 160, S 8, H M 552064, I/A 6 (14.01.15).

08 de Enero de 2015
Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 30679 , F 160, S 8, H M 552064, I/A 5(29.12.14).

09 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ DE CASTA脩EDA RODRIGUEZ HENAR. Datos registrales. T 30679 , F 159, S 8, H M 552064, I/A 4 (2.10.13).

08 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;GRACIACEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE DEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZBEGO脩A. Datos registrales. T 30679 , F 157, S 8, H M 552064, I/A 3 (27.02.13).

07 de Febrero de 2013
Cambio de domicilio social. C/ CABALLERO ANDANTE 8 - EDIFICIO ISOLUX CORSAN (MADRID). Datos registrales. T 30679 , F157, S 8, H M 552064, I/A 2 (30.01.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n