Buscador CIF Logo

Actos BORME Aparcamientos Segovia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aparcamientos Segovia Sl

Actos BORME Aparcamientos Segovia Sl - B40210023

Tenemos registrados 45 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aparcamientos Segovia Sl con CIF B40210023

馃敊 Perfil de Aparcamientos Segovia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aparcamientos Segovia Sl

10 de Noviembre de 2023
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 15/09/2023. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se aprueba la propuesta de convenio de la concursada. Datos registrales. T 27781 , F 223, S 8, H M 500629, I/A C (2.11.23).

29 de Marzo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ GENOVA, NUMERO 15, 1潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F 222, S 8, H M500629, I/A 39 (22.03.23).

04 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 27781 , F 221, S 8, H M 500629, I/A 38(27.10.22).

29 de Julio de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/06/2022. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se declara finalizada la fase com煤n del procedimiento concursal. Se abre la fase de convenio, form谩ndose la secci贸nquinta. Datos registrales. T 27781 , F 220, S 8, H M 500629, I/A B (21.07.22).

31 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: VIA OZALLA OSCAR;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;MARTIN CASTELLO FELIX. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GRACIA CEBOLLADAANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Man.Soli:

08 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ CANDIDO;LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYOESTEBAN;NAVAS-PAREJO MENDEZ EMILIO. Datos registrales. T 27781 , F 219, S 8, H M 500629, I/A 36 ( 1.06.21).

30 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN. Datosregistrales. T 27781 , F 218, S 8, H M 500629, I/A 35 (23.11.20).

29 de Octubre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ CRISTOBAL BORDIU 35 - ENTREPLANTA - LOCAL 1 (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F218, S 8, H M 500629, I/A 34 (22.10.20).

06 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: VERA VAZQUEZ FRANCISCO.Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 23潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 27781 , F 218, S 8, H M500629, I/A 33 (30.07.20).

27 de Enero de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Se declara la firmeza del auto de 29 de mayo de 2018 por el que se anot贸 la declaraci贸n de concurso de acreedores,nombramiento de administrador concursal. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n29/05/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se acumula el concurso al procedimiento 700/2017 del mismo juzgadocorrespondiente a la sociedad Grupo Isolux Corsan SA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fechade resoluci贸n 29/05/2018. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datosregistrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 32 (16.01.20).

31 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, HM 500629, I/A 31 (24.05.19).

31 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 30(21.12.18).

19 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: REINA PINTO JUAN CARLOS;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Nombramientos. Adm. Unico:REINA PINTO JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 29 (11.10.18).

29 de Junio de 2018
Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se declara en concurso de acreedores de car谩cter voluntario. Eldeudor conserva.las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio. Se acuerda la acumulaci贸n de los anterioresconcursos al que se tramita bajo los autos de concurso n煤mero 700/2017, para su tramitaci贸n coordinada bajo. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 779/2018. Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 29/05/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Datos registrales. T 27781 , F 216, S 8, H M 500629, I/A A (20.06.18).

26 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;RODRIGUEZ DORADOGONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;CRUZ CRUZ SANDRA;DE LAS CASAS GONZALEZ LUIS;ESPARZA TORRECILLA JESUS.Datos registrales. T 27781 , F 211, S 8, H M 500629, I/A 28 (18.12.17).

08 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 27781 , F 210, S 8, H M 500629, I/A 27 (30.10.17).

09 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;LIMONHOSTENCH JAIME;RODRIGUEZ DORADO GONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;MEDIANO LORENCI YOLANDA;CHAVESDECLARA JESUS;LOPEZ PEREZ ROBERTO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZCRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIA MARIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27781 , F 206, S 8, H M500629, I/A 26 (28.04.16).

22 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: REINA PINTOJUAN CARLOS. Datos registrales. T 27781 , F 206, S 8, H M 500629, I/A 25 (12.05.15).

07 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;VIEJO GONZALEZ DOLORES;VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE;HERNANDEZ MU脩OZANTONIO JESUS;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datos registrales. T 27781 , F 201, S 8, H M 500629, I/A 24 (26.03.15).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: VERA MARTINEZ RAUL;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datosregistrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 22 (24.03.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: BUSCA MARTIN SANZALVARO. Datos registrales. T 27781 , F 201, S 8, H M 500629, I/A 23 (24.03.15).

19 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 21 ( 9.01.15).

13 de Enero de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 20(30.12.14).

08 de Enero de 2015
Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 19(29.12.14).

12 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M500629, I/A 18 ( 5.05.14).

25 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M 500629, I/A 17(17.03.14).

19 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DURAN BARBARA. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M 500629, I/A 16(12.03.14).

15 de Noviembre de 2013
Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DON PEDRO GARCIA CREUS RUIZ BERDEJO , OTORGADO ENESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON SANTIAGO CARDELUS MU脩OZ SECA EL 24 DE ENERO DE2007 CON PROTOCOLO 269, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 4潞 DE TRASLADO Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M500629, I/A 15 ( 7.11.13).

29 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANOJESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;VIAOZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apoderado: GARCIA MATEOSMANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T27781 , F 197, S 8, H M 500629, I/A 14 (20.05.13).

11 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Apo.Manc.: GOMEZMARTINEZ CRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datosregistrales. T 27781 , F 195, S 8, H M 500629, I/A 12 (29.11.12).

Revocaciones. Apoderado: SAR GOMEZ EUGENIO RAMON. Datos registrales. T 27781 , F 196, S 8, H M 500629, I/A 13(29.11.12).

06 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;SENDARRUBIAS REDONDO JOSE MARIA;CABALLEROFERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 11 (27.06.12).

14 de Junio de 2012
Revocaciones. Apoderado: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSE DEMETRIO;MESTRE MORALESALBO JOSE DEMETRIO. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 10 ( 1.06.12).

25 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBEJESUS;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 9 (16.05.12).

21 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 8 ( 9.02.12).

22 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T 27781 , F 135, S 8, H M 500629, I/A 7(10.11.11).

05 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;SALMERON UNTURBEJESUS;CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSEDEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;SAR GOMEZ EUGENIO RAMON;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datos registrales. T 27781 , F 133, S 8, H M 500629, I/A 6 (25.10.10).

10 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27781 , F 132, S 8, H M 500629, I/A 5 (24.08.10).

08 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: VIA OZALLA OSCAR. Datos registrales. T 27781 , F 130, S 8, H M 500629, I/A 3 (24.08.10).

Otros conceptos: REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DON JOSE LUIS MESEGUER VELASCO, DON ESTEBANPIJOAN MARIN Y A DON ALVARO RENGIFO ABBAD. Datos registrales. T 27781 , F 131, S 8, H M 500629, I/A 4 (24.08.10).

11 de Junio de 2010
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ CABALLERO ANDANTE ( 8,EDIFICIO ISOLUX CORSAMADRID). Datos registrales. T 27781 , F 119, S 8, H M 500629, I/A 2 (28.05.10).

26 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE. Datosregistrales. T 199 , F 208, S 8, H SG 4421, I/A 8 (16.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALMERON UNTURBE JESUS. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;VALENZUELACONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE. Datos registrales. T 199 , F 209, S 8, H SG4421, I/A 9 (16.03.10).

17 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA MARCO JUAN;ZAMORANO LEYVA JUAN-ANTONIO. Datos registrales. T 199 , F 208, S 8, HSG 4421, I/A 6 ( 6.03.09).

Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DAPENA FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 199 , F 208, S 8, H SG 4421, I/A 7 (6.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n