Actos BORME de Aparcamientos Segovia Sl
10 de Noviembre de 2023Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 15/09/2023. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se aprueba la propuesta de convenio de la concursada. Datos registrales. T 27781 , F 223, S 8, H M 500629, I/A C (2.11.23).
29 de Marzo de 2023Cambio de domicilio social. C/ GENOVA, NUMERO 15, 1潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F 222, S 8, H M500629, I/A 39 (22.03.23).
04 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 27781 , F 221, S 8, H M 500629, I/A 38(27.10.22).
29 de Julio de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/06/2022. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS.Resoluciones: Se declara finalizada la fase com煤n del procedimiento concursal. Se abre la fase de convenio, form谩ndose la secci贸nquinta. Datos registrales. T 27781 , F 220, S 8, H M 500629, I/A B (21.07.22).
31 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: VIA OZALLA OSCAR;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;MARTIN CASTELLO FELIX. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;DE EGA脩AHUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GRACIA CEBOLLADAANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Man.Soli:
08 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ CANDIDO;LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYOESTEBAN;NAVAS-PAREJO MENDEZ EMILIO. Datos registrales. T 27781 , F 219, S 8, H M 500629, I/A 36 ( 1.06.21).
30 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: LIMON HOSTENCH JAIME;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN. Datosregistrales. T 27781 , F 218, S 8, H M 500629, I/A 35 (23.11.20).
29 de Octubre de 2020Cambio de domicilio social. C/ CRISTOBAL BORDIU 35 - ENTREPLANTA - LOCAL 1 (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F218, S 8, H M 500629, I/A 34 (22.10.20).
06 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: VERA VAZQUEZ FRANCISCO.Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 23潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 27781 , F 218, S 8, H M500629, I/A 33 (30.07.20).
27 de Enero de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: Se declara la firmeza del auto de 29 de mayo de 2018 por el que se anot贸 la declaraci贸n de concurso de acreedores,nombramiento de administrador concursal. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n29/05/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se acumula el concurso al procedimiento 700/2017 del mismo juzgadocorrespondiente a la sociedad Grupo Isolux Corsan SA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME: Si, Fechade resoluci贸n 29/05/2018. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datosregistrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 32 (16.01.20).
31 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, HM 500629, I/A 31 (24.05.19).
31 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 30(21.12.18).
19 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: REINA PINTO JUAN CARLOS;AVILA ALVAREZ FEDERICO. Nombramientos. Adm. Unico:REINA PINTO JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 27781 , F 217, S 8, H M 500629, I/A 29 (11.10.18).
29 de Junio de 2018Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 779/2018. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se declara en concurso de acreedores de car谩cter voluntario. Eldeudor conserva.las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio. Se acuerda la acumulaci贸n de los anterioresconcursos al que se tramita bajo los autos de concurso n煤mero 700/2017, para su tramitaci贸n coordinada bajo. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 779/2018. Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 29/05/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Datos registrales. T 27781 , F 216, S 8, H M 500629, I/A A (20.06.18).
26 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;RODRIGUEZ DORADOGONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;CRUZ CRUZ SANDRA;DE LAS CASAS GONZALEZ LUIS;ESPARZA TORRECILLA JESUS.Datos registrales. T 27781 , F 211, S 8, H M 500629, I/A 28 (18.12.17).
08 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 27781 , F 210, S 8, H M 500629, I/A 27 (30.10.17).
09 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;REINA PINTO JUAN CARLOS;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;LIMONHOSTENCH JAIME;RODRIGUEZ DORADO GONZALO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;MEDIANO LORENCI YOLANDA;CHAVESDECLARA JESUS;LOPEZ PEREZ ROBERTO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZCRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIA MARIA SANDRA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27781 , F 206, S 8, H M500629, I/A 26 (28.04.16).
22 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: REINA PINTOJUAN CARLOS. Datos registrales. T 27781 , F 206, S 8, H M 500629, I/A 25 (12.05.15).
07 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;BUSCA MARTIN SANZ ALVARO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;JIMENEZ AGUAYO ESTEBAN;VIEJO GONZALEZ DOLORES;VERA MARTINEZ RAUL ENRIQUE;HERNANDEZ MU脩OZANTONIO JESUS;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datos registrales. T 27781 , F 201, S 8, H M 500629, I/A 24 (26.03.15).
01 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: VERA MARTINEZ RAUL;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;GARRIDO ESPA MIGUEL. Datosregistrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 22 (24.03.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: BUSCA MARTIN SANZALVARO. Datos registrales. T 27781 , F 201, S 8, H M 500629, I/A 23 (24.03.15).
19 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 21 ( 9.01.15).
13 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 20(30.12.14).
08 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 27781 , F 200, S 8, H M 500629, I/A 19(29.12.14).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M500629, I/A 18 ( 5.05.14).
25 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M 500629, I/A 17(17.03.14).
19 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DURAN BARBARA. Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M 500629, I/A 16(12.03.14).
15 de Noviembre de 2013Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DON PEDRO GARCIA CREUS RUIZ BERDEJO , OTORGADO ENESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON SANTIAGO CARDELUS MU脩OZ SECA EL 24 DE ENERO DE2007 CON PROTOCOLO 269, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 4潞 DE TRASLADO Datos registrales. T 27781 , F 199, S 8, H M500629, I/A 15 ( 7.11.13).
29 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANOJESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;VIAOZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apoderado: GARCIA MATEOSMANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T27781 , F 197, S 8, H M 500629, I/A 14 (20.05.13).
11 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Apo.Manc.: GOMEZMARTINEZ CRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datosregistrales. T 27781 , F 195, S 8, H M 500629, I/A 12 (29.11.12).
Revocaciones. Apoderado: SAR GOMEZ EUGENIO RAMON. Datos registrales. T 27781 , F 196, S 8, H M 500629, I/A 13(29.11.12).
06 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;SENDARRUBIAS REDONDO JOSE MARIA;CABALLEROFERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 11 (27.06.12).
14 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSE DEMETRIO;MESTRE MORALESALBO JOSE DEMETRIO. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 10 ( 1.06.12).
25 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBEJESUS;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 9 (16.05.12).
21 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 27781 , F 194, S 8, H M 500629, I/A 8 ( 9.02.12).
22 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T 27781 , F 135, S 8, H M 500629, I/A 7(10.11.11).
05 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;SALMERON UNTURBEJESUS;CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSEDEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;SAR GOMEZ EUGENIO RAMON;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datos registrales. T 27781 , F 133, S 8, H M 500629, I/A 6 (25.10.10).
10 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27781 , F 132, S 8, H M 500629, I/A 5 (24.08.10).
08 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: VIA OZALLA OSCAR. Datos registrales. T 27781 , F 130, S 8, H M 500629, I/A 3 (24.08.10).
Otros conceptos: REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DON JOSE LUIS MESEGUER VELASCO, DON ESTEBANPIJOAN MARIN Y A DON ALVARO RENGIFO ABBAD. Datos registrales. T 27781 , F 131, S 8, H M 500629, I/A 4 (24.08.10).
11 de Junio de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ CABALLERO ANDANTE ( 8,EDIFICIO ISOLUX CORSAMADRID). Datos registrales. T 27781 , F 119, S 8, H M 500629, I/A 2 (28.05.10).
26 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE. Datosregistrales. T 199 , F 208, S 8, H SG 4421, I/A 8 (16.03.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALMERON UNTURBE JESUS. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;VALENZUELACONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE. Datos registrales. T 199 , F 209, S 8, H SG4421, I/A 9 (16.03.10).
17 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA MARCO JUAN;ZAMORANO LEYVA JUAN-ANTONIO. Datos registrales. T 199 , F 208, S 8, HSG 4421, I/A 6 ( 6.03.09).
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DAPENA FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 199 , F 208, S 8, H SG 4421, I/A 7 (6.03.09).