Actos BORME de Aparcamientos Zona Franca Sl
13 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CAD. Nombramientos. Adm.Unico: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CAD. Datos registrales. T 2078 , F 30, S 8, H CA 19676, I/A43 ( 1.06.22).
03 de Febrero de 2020Otros conceptos: Inscrita la dimisión de Don Ignacio Javier Gutierrez Arévalo como Representante Pesona Física del AdministradorUnico, "Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz S.M.E., ;.P., S.A.U" y nombrada en su sustitición a Doña María PilarGonzález Vázquez. Datos registrales. T 2078 , F 29, S 8, H CA 19676, I/A 42 (27.01.20).
03 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: LARA FERNANDEZ CAMILO JOSE. Datos registrales. T 2078 , F 29, S 8, H CA 19676, I/A 41(25.09.18).
27 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CAD. Nombramientos. Adm.Unico: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CAD. Datos registrales. T 2078 , F 29, S 8, H CA 19676, I/A40 (19.07.17).
15 de Marzo de 2017Otros conceptos: Cambio de representante persona física del administrador único de esta sociedad "Desarrollos Empresariales de laZona Franca de Cádiz SAU" que pasa a ser Don Ignacio Javier Gutiérrez Arévalo. Datos registrales. T 2078 , F 28, S 8, H CA 19676,I/A 39 ( 7.03.17).
25 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL;FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2078 ,F 27, S 8, H CA 19676, I/A 36 (13.04.16).
Revocaciones. Apoderado: BARCELONA LOZANO TANIA. Datos registrales. T 2078 , F 28, S 8, H CA 19676, I/A 37 (13.04.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: LARA FERNANDEZ CAMILO JOSE. Datos registrales. T 2078 , F 28, S 8, H CA 19676, I/A 38(13.04.16).
16 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO GARCIA LUISA. Datos registrales. T 2078 , F 27, S 8, H CA 19676, I/A 35( 7.08.13).
10 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ AREVALO IGNACIO JAVIER;TABOADA CORZO FELIX. Datos registrales. T 2078 , F 27, S8, H CA 19676, I/A 31 ( 3.04.13).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ TEY MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2078 , F 27, S 8, H CA 19676, I/A 32 (3.04.13).
Revocaciones. Apoderado: PENCO GALLE RAQUEL CAROLINA. Datos registrales. T 2078 , F 27, S 8, H CA 19676, I/A 33 (3.04.13).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ MARIA ARGENTINA. Datos registrales. T 2078 , F 27, S 8, H CA 19676, I/A34 ( 3.04.13).
21 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1881 , F 82, S 8, H CA 19676, I/A 30(12.03.13).
04 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: BARCELONA LOZANO TANIA. Datos registrales. T 1881 , F 82, S 8, H CA 19676, I/A 29 (24.12.12).
27 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL. Consejero: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ.Presidente: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ. Cons.Del.Sol: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ.Consejero: TABOADA CORZO FELIX;GONZALEZ ARAGON MARIA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: DESARROLLOSEMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CAD. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejode administración a Administrador único.ARTICULO VIGESIMOPRIMERO.- RESUMEN.ARTICULO VIGESIMOCUARTO.-RESUMEN.ARTICULO VIGESIMOQUINTO.-RESUMEN.ARTICULO VIGESIMOSEXTO.- Resumen. Datos registrales. T 1881 , F 81,S 8, H CA 19676, I/A 28 (13.11.12).
16 de Octubre de 2012Reelecciones. Consejero: TABOADA CORZO FELIX;GONZALEZ ARAGON MARIA ISABEL. Datos registrales. T 1881 , F 81, S 8,H CA 19676, I/A 27 ( 1.10.12).
27 de Febrero de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DECAD. Datos registrales. T 1881 , F 81, S 8, H CA 19676, I/A 26 (14.02.12).
09 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Secretario: FEDRIANI CASTROJOSE MANUEL. Datos registrales. T 1881 , F 80, S 8, H CA 19676, I/A 25 (30.01.12).
03 de Septiembre de 2010Reelecciones. Consejero: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ. Presidente: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DECADIZ. Cons.Del.Sol: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ. Datos registrales. T 1881 , F 80, S 8, H CA 19676, I/A 24(24.08.10).
04 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1881 , F 79, S 8, H CA 19676, I/A 23(21.12.09).
04 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ MARIA ARGENTINA. Datos registrales. T 1881 , F 79, S 8, H CA 19676, I/A22 (25.05.09).
27 de Abril de 2009Reelecciones. Consejero: TABOADA CORZO FELIX;GONZALEZ ARAGON MARIA ISABEL. Datos registrales. T 1881 , F 79, S 8,H CA 19676, I/A 21 (16.04.09).
02 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: PENCO GALLE RAQUEL CAROLINA. Datos registrales. T 1881 , F 78, S 8, H CA 19676, I/A 20(18.02.09).
20 de Enero de 2009Revocaciones. Apoderado: FEDRIANI CASTRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1881 , F 78, S 8, H CA 19676, I/A 19 (7.01.09).