Actos BORME de Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea Centro De Transportes De Bizkaia Sociedad Anonima
25 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUIRRE ARRARTE MIGUEL. Nombramientos. Consejero: LEKUE SARATXO NURIA. Datosregistrales. T 5625 , F 197, S 8, H BI 4883,A , I/ 88 .(11.04.23).
19 de Enero de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.812.322,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.208.707,00 Euros. Datos registrales. T5625 , F 197, S 8, H BI 4883,A , I/ 87 .(10.01.23).
21 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5625 , F 197, S 8, H BI 4883,A ,I/ 86 .( 5.12.22).
24 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PE脩ACOBA ETXEBARRIA MIREN MAITE;BILBAO BEGO脩A JOSU. Nombramientos. Consejero:BILBAO BEGO脩A JOSU;O脩ATE ZAMALLOA IBON. Datos registrales. T 5625 , F 196, S 8, H BI 4883,A , I/ 85 .(17.02.22).
07 de Octubre de 2021Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 32, 33, 34 Y 36 DEESTATUTOS.. Datos registrales. T 5625 , F 194, S 8, H BI 4883,A , I/ 84 .(27.09.21).
04 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: QUIJADA GARRIDO ANA BELEN;GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL;MARTINEZ BARTOLOME VIDAL.Datos registrales. T 5625 , F 194, S 8, H BI 4883,A , I/ 83 .(24.12.20).
24 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GURUTZEAGA ZUBILLAGA MIKEL;GOENAGA EGIBAR IMANOL. Nombramientos. Consejero:MARCO DE LA PE脩A LUIS PEDRO;DE JUAN DE MIGUEL MARIA DOLORES. Datos registrales. T 5625 , F 194, S 8, H BI 4883,A ,I/ 82 .(15.12.20).
03 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 99.663,00 Euros. Desembolsado: 99.663,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.021.029,00 Euros.Resultante Desembolsado: 30.021.029,00 Euros. Datos registrales. T 5625 , F 193, S 8, H BI 4883,A , I/ 81 .(21.01.20).
26 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ BARTOLOME VIDAL;O脩ATE ZAMALLOA IBON;LARREA ARRUTIA JONERRAIMUNDA;GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR;COBO PRESILLA AITOR;PIZARRO FURONES JUAN ANTONIO;AZKUEORBEA BERNARDO. Secretario: O脩ATE ZAMALLOA IBON. Vicepresid.: MARTINEZ BARTOLOME VIDAL. Consejero: GOENAGAEGIBAR IMANOL;GURUTZEAGA ZUBILLAGA MIKEL;GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL;AGUIRRE ARRARTE MIGUEL. Presidente:GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL. Consejero: PE脩ACOBA ETXEBARRIA MIREN MAITE. Nombramientos. Consejero: GOMEZ VIARMIGUEL ANGEL;MARTINEZ BARTOLOME VIDAL;GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR;COBO PRESILLA AITOR;LARREAARRUTIA JON ERRAIMUNDA;PE脩ACOBA ETXEBARRIA MIREN MAITE;BILBAO BEGO脩A JOSU;PIZARRO FURONES JUANANTONIO;PEREZ DE PALOMAR ALONSO JAVIER;GURUTZEAGA ZUBILLAGA MIKEL;GOENAGA EGIBAR IMANOL;AGUIRREARRARTE MIGUEL. Presidente: GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: MARTINEZ BARTOLOME VIDAL. SEC.NOMIEMB.:PIZARRO FURONES JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 5625 , F 192, S 8, H BI 4883,A , I/ 80 .(17.12.19).
27 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ISLA LLONA LUCIA. Nombramientos. Consejero: PE脩ACOBA ETXEBARRIA MIREN MAITE.Datos registrales. T 5625 , F 192, S 8, H BI 4883,A , I/ 79 .(18.06.19).
22 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: REYES MARTIN JOSE VICENTE;GARCIA DE MI脩AUR ROTAECHE GONZALO. Presidente: REYESMARTIN JOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL;AGUIRRE ARRARTE MIGUEL. Presidente:GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5625 , F 189, S 8, H BI 4883,A , I/ 76 .(12.02.19).
Revocaciones. Apoderado: SEOANE ICARAN FRANCISCO JAVIER;REYES MARTIN JOSE VICENTE;MARTINEZ BARTOLOMEVIDAL. Nombramientos. Apoderado: SEOANE ICARAN FRANCISCO JAVIER;GOMEZ VIAR MIGUEL ANGEL;MARTINEZBARTOLOME VIDAL. Datos registrales. T 5625 , F 190, S 8, H BI 4883,A , I/ 77 .(12.02.19).
Reelecciones. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5625 , F 192, S 8, H BI 4883,A ,I/ 78 .(13.02.19).
26 de Septiembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 99.663,00 Euros. Desembolsado: 99.663,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.921.366,00 Euros.Resultante Desembolsado: 29.921.366,00 Euros. Datos registrales. T 5625 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 75 .(19.09.18).
16 de Octubre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 99.663,00 Euros. Desembolsado: 99.663,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.821.703,00 Euros.Resultante Desembolsado: 29.821.703,00 Euros. Datos registrales. T 5625 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 74 .( 4.10.17).
27 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA AVELINO;RUIZ DE ANGULO DEL CAMPO ALMUDENA.Nombramientos. Consejero: GOENAGA EGIBAR IMANOL;GURUTZEAGA ZUBILLAGA MIKEL. Datos registrales. T 5625 , F 187,S 8, H BI 4883,A , I/ 73 .(15.03.17).
11 de Agosto de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 680.911,00 Euros. Desembolsado: 680.911,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.722.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 29.722.040,00 Euros. Datos registrales. T 5625 , F 187, S 8, H BI 4883,A , I/ 72 .(26.07.16).
27 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5109 , F 192, S 8, H BI 4883,A ,I/ 71 .(11.07.16).
11 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.499.486,00 Euros. Desembolsado: 1.499.486,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.041.129,00 Euros.Resultante Desembolsado: 29.041.129,00 Euros. Datos registrales. T 5109 , F 192, S 8, H BI 4883,A , I/ 70 .( 1.02.16).
11 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GARAMENDI LANDA ITZIAR. Presidente: GARAMENDI LANDA ITZIAR. Consejero: BERGARETXELARREA IKER. Vicepresid.: BERGARETXE LARREA IKER. Consejero: IRIONDO BILBAO MIKEL;ESCRIBANO ETXEBARRIAJOSEBA;GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR;COBO PRESILLA AITOR;ISLA LLONA LUCIA;DEL CAMPO BERASATEGUIAMAIA;LOPEZ BENAVENTE HEIKO;GARCIA MI脩AUR ROTAECHE GONZALO. Secretario: IRIONDO BILBAO MIKEL. Consejero:RUIZ DE ANGULO DEL CAMPO ALMUDENA;FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA AVELINO. Nombramientos. Consejero:REYES MARTIN JOSE VICENTE;MARTINEZ BARTOLOME VIDAL;O脩ATE ZAMALLOA IBON;LARREA ARRUTIA JONERRAIMUNDA;ISLA LLONA LUCIA;GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR;COBO PRESILLA AITOR;PIZARRO FURONESJUAN ANTONIO;AZKUE ORBEA BERNARDO;FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA AVELINO;RUIZ DE ANGULO DEL CAMPOALMUDENA;GARCIA DE MI脩AUR ROTAECHE GONZALO. Secretario: O脩ATE ZAMALLOA IBON. Presidente: REYES MARTINJOSE VICENTE. Vicepresid.: MARTINEZ BARTOLOME VIDAL. Datos registrales. T 5109 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 68.(28.12.15).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: PEREZ NOVALES AITOR. Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ UGALDE JOSERAMON;MARTIARTU ARTEAGA JAIONE. Nombramientos. Apoderado: SEOANE ICARAN FRANCISCO JAVIER;REYES MARTINJOSE VICENTE;MARTINEZ BARTOLOME VIDAL. Datos registrales. T 5109 , F 189, S 8, H BI 4883,A , I/ 69 .(28.12.15).
20 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LEZA OLAIZOLA MANUEL. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ DE QUINCOCESMENDIETA AVELINO. Datos registrales. T 5109 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 67 .( 7.05.15).
25 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.499.486,00 Euros. Desembolsado: 1.499.486,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.541.643,00 Euros.Resultante Desembolsado: 27.541.643,00 Euros. Datos registrales. T 582 , F 225, S 8, H BI 4883,A , I/ 66 .(12.09.14).
24 de Febrero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 26.348.343,03 Euros. Resultante Suscrito: 26.042.157,00 Euros. P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.aparkabisa.com. Datos registrales. T 582 , F 224, S 8, H BI 4883,A , I/ 65.(17.02.14).
09 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.499.646,39 Euros. Desembolsado: 1.499.646,39 Euros. Resultante Suscrito: 52.390.500,03 Euros.Resultante Desembolsado: 52.390.500,03 Euros. Datos registrales. T 582 , F 223, S 8, H BI 4883,A , I/ 63 .(16.12.13).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: LEKUE ARROLA JOSE MARIA. Nombramientos. Dir. General: PEREZ NOVALES AITOR. Datosregistrales. T 582 , F 224, S 8, H BI 4883,A , I/ 64 .(27.12.13).
23 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 582 , F 222, S 8, H BI 4883,A, I/ 62 .( 9.12.13).
10 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPA脩A GUZMAN JOSE LUIS;PREGO LARREINA JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero:LEZA OLAIZOLA MANUEL;RUIZ DE ANGULO DEL CAMPO ALMUDENA. Datos registrales. T 582 , F 222, S 8, H BI 4883,A , I/ 61.(28.05.13).
15 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.499.646,39 Euros. Desembolsado: 1.499.646,39 Euros. Resultante Suscrito: 50.890.853,64 Euros.Resultante Desembolsado: 50.890.853,64 Euros. Datos registrales. T 582 , F 221, S 8, H BI 4883,A , I/ 60 .( 7.01.13).
28 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MOSTAJO BILBAO ALBERTO;ESTEFANIA ANGULO CARLOS;GONZALEZ DE HEREDIA MARURICESAR;COBO PRESILLA AITOR;ISLA LLONA LUCIA;BERGARETXE LARREA IKER;DEL CAMPO BERASATEGIAMAIA;SANTIESTEBAN GUTIERREZ AINHOA. Vicepresid.: MOSTAJO BILBAO ALBERTO. Secretario: ESTEFANIA ANGULOCARLOS. Consejero: ARDANZA URIBARREN MARIA PILAR;BENAITO VILLAGARCIA JESUS MARIA. Presidente: ARDANZAURIBARREN MARIA PILAR. Consejero: ESPA脩A GUZMAN JOSE LUIS;GARCIA-MI脩AUR ROTAECHE GONZALO;BENAITOVILLAGARCIA JESUS MARIA. Nombramientos. Consejero: GARAMENDI LANDA ITZIAR. Presidente: GARAMENDI LANDAITZIAR. Consejero: BERGARETXE LARREA IKER. Vicepresid.: BERGARETXE LARREA IKER. Consejero: IRIONDO BILBAOMIKEL;ESCRIBANO ETXEBARRIA JOSEBA;GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR;COBO PRESILLA AITOR;ISLA LLONALUCIA;ESPA脩A GUZMAN JOSE LUIS;BENAITO VILLAGARCIA JESUS MARIA;DEL CAMPO BERASATEGUI AMAIA;LOPEZBENAVENTE HEIKO;GARCIA MI脩AUR ROTAECHE GONZALO. Secretario: IRIONDO BILBAO MIKEL. Consejero: PREGOLARREINA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 582 , F 221, S 8, H BI 4883,A , I/ 59 .(15.05.12).
28 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.749.667,59 Euros. Desembolsado: 1.749.667,59 Euros. Resultante Suscrito: 49.391.207,25 Euros.Resultante Desembolsado: 49.391.207,25 Euros. Datos registrales. T 582 , F 220, S 8, H BI 4883,A , I/ 58 .(16.11.11).
11 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCRIBANO RIEGO MARIA MANUELA;MARTINEZ HOYOS JESUS. Nombramientos. Consejero:ESPA脩A GUZMAN JOSE LUIS;GARCIA-MI脩AUR ROTAECHE GONZALO. Datos registrales. T 582 , F 219, S 8, H BI 4883,A , I/ 57.(30.03.11).
04 de Abril de 2011Nombramientos. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 582 , F 219, S 8, H BI 4883,A, I/ 56 .(23.03.11).
31 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: ZUBIZARRETA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 582 , F 219, S 8, H BI 4883,A, I/ 55 .(16.12.10).
04 de Octubre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.500.212,00 Euros. Desembolsado: 2.500.212,00 Euros. Resultante Suscrito: 47.641.539,66 Euros.Resultante Desembolsado: 47.641.539,66 Euros. Datos registrales. T 582 , F 218, S 8, H BI 4883,A , I/ 54 .(16.09.10).
10 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: GO脩I HERNANDEZ RICARDO;BASARRATE SANGRONIZ ROMAN;GUERRERO LOBO TEOBALDO.Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ UGALDE JOSE RAMON;MARTIARTU ARTEAGA JAIONE;LEKUE ARROLA JOSE MARIA.Datos registrales. T 582 , F 218, S 8, H BI 4883,A , I/ 53 .(28.05.10).
30 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GARAMENDI LANDA ITZIAR;EMBID ZUBIRIA ZURI脩E;ELKOROIRIBE ZENIKAONAINDIA MIREIA.Presidente: GARAMENDI LANDA ITZIAR. Nombramientos. Consejero: ARDANZA URIBARREN MARIA PILAR;BENAITOVILLAGARCIA JESUS MARIA;ESCRIBANO RIEGO MARIA MANUELA. Presidente: ARDANZA URIBARREN MARIA PILAR. Datosregistrales. T 582 , F 217, S 8, H BI 4883,A , I/ 52 .(16.03.10).
19 de Octubre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.500.212,00 Euros. Desembolsado: 2.500.212,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.141.327,66 Euros.Resultante Desembolsado: 45.141.327,66 Euros. Datos registrales. T 582 , F 217, S 8, H BI 4883,A , I/ 51 .( 5.10.09).