Buscador CIF Logo

Actos BORME Apartamentos Surfing Playa Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Apartamentos Surfing Playa Sa

Actos BORME Apartamentos Surfing Playa Sa - A07088479

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Apartamentos Surfing Playa Sa con CIF A07088479

🔙 Perfil de Apartamentos Surfing Playa Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Apartamentos Surfing Playa Sa

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ FERNANDEZ BUGALLAL ALVARO MARIA. Datos registrales. T 34961 , F 63, S 8, H M 628798,I/A 16 ( 5.10.22).

Nombramientos. Apoderado: CALLEJO VILLADANGOS EVA MARIA;CALIXTE FABIEN. Datos registrales. T 34961 , F 64, S 8, H M628798, I/A 17 ( 5.10.22).

12 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: HERAULT BENOIT JEAN PIERRE. Nombramientos. Representan: BAYON LOUIS FREDERIC.Datos registrales. T 34961 , F 63, S 8, H M 628798, I/A 15 ( 5.05.22).

05 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FAUCHER CAROLE;DARIUS NICOLAS. Datos registrales. T 34961 , F 63, S 8, H M 628798, I/A 14(27.04.22).

11 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANZ ARRECHEA JAVIER. Datos registrales. T 34961 , F 62, S 8, H M 628798, I/A 13 ( 4.04.22).

18 de Marzo de 2022
Reelecciones. Adm. Unico: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA. Representan: HERAULT BENO-T JEAN PIERRE. Datosregistrales. T 34961 , F 62, S 8, H M 628798, I/A 12 (11.03.22).

11 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: PAZ CHOCANO ALEXIA MADELEINE;JIMENEZ FERNANDEZ BUGALLAL ALVARO MARIA;SANZARRECHEA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34961 , F 62, S 8, H M 628798, I/A 11 ( 2.12.20).

10 de Julio de 2020
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ FERNANDEZ BUGALLAL ALVARO MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZFERNANDEZ BUGALLAL ALVARO MARIA. Datos registrales. T 34961 , F 61, S 8, H M 628798, I/A 10 ( 3.07.20).

30 de Abril de 2020
Nombramientos. Apoderado: SANZ ARRECHEA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34961 , F 61, S 8, H M 628798, I/A 9(22.04.20).

20 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: DERYCKE PHILIPPINE SOPHIE MARIE JOSEPH. Nombramientos. Representan: HERAULTBENO-T JEAN PIERRE. Datos registrales. T 34961 , F 60, S 8, H M 628798, I/A 8 (13.03.20).

18 de Marzo de 2020
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 16 5 - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 34961 , F 60, S 8, H M 628798, I/A 7(11.03.20).

11 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: BEJARANO CARRERA DENISE. Datos registrales. T 34961 , F 60, S 8, H M 628798, I/A 6 ( 4.06.18).

08 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ FERNANDEZ BUGALLAL ALVARO MARIA. Datos registrales. T 34961 , F 59, S 8, H M628798, I/A 5 ( 1.02.18).

27 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE ARANDA 22 5º - IZDA (MADRID). Datos registrales. T 34961 , F 59, S 8, H M 628798,I/A 4 (19.12.17).

25 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: BLANQ ADRIEN SYLVAIN. Nombramientos. Representan: DERYCKE PHILIPPINE SOPHIEMARIE JOSEPH. Datos registrales. T 34961 , F 59, S 8, H M 628798, I/A 3 (13.09.17).

26 de Junio de 2017
Cambio de domicilio social. C/ DE ALCALA 95 7º I (MADRID). Datos registrales. T 34961 , F 59, S 8, H M 628798, I/A 2(16.06.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información