Actos BORME de Apartur Marinas De Nerja Sl
19 de Junio de 2023Otros conceptos: DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO: NUEVO SOCIO UNICO: CLUBOTEL LA DORADA S.L. Datosregistrales. T 48789 , F 184, S 8, H B 596368, I/A 24 (12.06.23).
29 de Mayo de 2023Cambio de domicilio social. CL CALABRIA Num.129 P.EN (BARCELONA). Datos registrales. T 48789 , F 184, S 8, H B 596368,I/A 23 (18.05.23).
21 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARRAU RIBERA JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: BARRAU PUY IGNACIO. Datosregistrales. T 5754, L 4661, F 108, S 8, H MA 23022, I/A 22 (12.12.22).
06 de Abril de 2022Nombramientos. Auditor: QS AUDIT CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 108, S 8, H MA 23022, I/A 20(25.03.22).
Nombramientos. Apoderado: OBISPO ALEZONES ARLIET CAROLINA. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 108, S 8, H MA23022, I/A 21 (25.03.22).
25 de Junio de 2019Nombramientos. Auditor: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 107, S 8, H MA 23022, I/A 18(14.06.19).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARTINEZ GONZALO. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 108, S 8, H MA 23022, I/A 19(14.06.19).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: BUESA AZNAR EMERITO. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 107, S 8, H MA 23022, I/A 17(22.05.19).
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOLEDO GONZALEZ JOSE GUILLERMO;MARTIN REYES GABRIEL;RODRIGUEZ HERIDA JOSEANTONIO. Datos registrales. T 5754, L 4661, F 107, S 8, H MA 23022, I/A 16 (27.09.18).
06 de Agosto de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: IRIDIUM RISING INVESTMENTS SL. Ceses/Dimisiones. Adm.Solid.: FRIAS MARCOS SEBASTIAN;FRIAS IBEAS VICTOR. Revocaciones. Apoderado: MARTIN REYES GABRIEL;RODRIGUEZMERIDA JOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli: TOLEDO GONZALEZ JOSE GUILLERMO. Nombramientos. Adm. Unico: BARRAURIBERA JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.Datos registrales. T 1762, L 675, F 144, S 8, H MA 23022, I/A 15 (26.07.18).
25 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOLEDO GONZALEZ JOSE GUILLERMO. Datos registrales. T 1762, L 675, F 144, S 8, H MA23022, I/A 14 (13.09.17).
05 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: HOFFMANN PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 1762, L 675, F 144, S 8, H MA 23022, I/A 13(25.04.17).
23 de Marzo de 2017Declaración de unipersonalidad. Socio único: INVERSIONES FRIAS SL. Datos registrales. T 1762, L 675, F 144, S 8, H MA23022, I/A 12 (13.03.17).
26 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FRIAS MARCOS VICTOR. Nombramientos. Adm. Solid.: FRIAS IBEAS VICTOR. Datosregistrales. T 1762, L 675, F 143, S 8, H MA 23022, I/A 11 (18.10.16).
03 de Octubre de 2016Nombramientos. Auditor: EUDITA BURGOS A&C ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 1762, L 675, F 143, S 8, H MA 23022, I/A10 (22.09.16).
03 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARTINEZ GONZALO. Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA 23022, I/A 9(26.08.15).
13 de Junio de 2013Nombramientos. Auditor: CASTELLANA DE AUDITORIA Y GESTION SLP. Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA23022, I/A 8 ( 5.06.13).
25 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: A&C ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA 23022, I/A 7 (10.01.12).
22 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FRIAS MARCOS FELIX. Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA 23022, I/A 5 ( 7.12.11).
Nombramientos. Apoderado: HOFFMANN PEREZ FERNANDO;MARTIN REYES GABRIEL;RODRIGUEZ MERIDA JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA 23022, I/A 6 ( 7.12.11).
11 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: A&C ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 1762, L 675, F 142, S 8, H MA 23022, I/A 4 (29.03.11).