Actos BORME de Apex Ingenieria Integral Sa
11 de Marzo de 2021Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 22/10/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS. Juez:JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n22/10/2020. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1DE BURGOS. Juez: JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. Fecha deresoluci贸n 27/10/2014. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. Juez:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 22/10/2020, NIF/CIF 13123224E. VADILLO ZABALLOS PASCUAL.Extinci贸n. Datos registrales. T 657, L 448, F 195, S 8, H BU 2896, I/A 22 ( 5.03.21).
09 de Febrero de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/01/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. Juez: JOSE MARIA TAPIA LOPEZ. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/01/2015. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS.Juez: JOSE MARIA TAPIA LOPEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. Fecha de resoluci贸n 27/10/2014.Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. Juez: JOSE MARIA TAPIA LOPEZ.Administrador Concursal. Fecha 27/10/2014, NIF/CIF 13123224E. VADILLO ZABALLOS PASCUAL. Datos registrales. T 657, L 448,F 195, S 8, H BU 2896, I/A 20 ( 3.02.15).
11 de Diciembre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 27/10/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. Juez: JOSE MARIA TAPIA LOPEZ. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 481/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 27/10/2014. Resoluciones acordando la intervenci贸no suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DEBURGOS. Juez: JOSE MARIA TAPIA LOPEZ. Datos registrales. T 657, L 448, F 194, S 8, H BU 2896, I/A A ( 3.12.14).
31 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RENES DOMINGO LUIS. Presidente: RENES DOMINGO LUIS. Consejero: GONZALEZ DE LAIGLESIA JAIME. Secretario: GONZALEZ DE LA IGLESIA JAIME. Consejero: ARANDA MARTINEZ TOMAS;ARAUZO ORTEGAIGNACIO;TORRADO REVILLA JAVIER;PE脩ACOBA CASCAJARES FERNANDO LUIS. Vicesecret.: ARAUZO ORTEGA IGNACIO.Consejero: MONJE PARDO JUAN CARLOS. Revocaciones. Apoderado: RENES DOMINGO LUIS. Apo.Sol.: GONZALEZ DE LAIGLESIA JAIME. Nombramientos. Consejero: TORRADO REVILLA JAVIER;ARAUZO ORTEGA IGNACIO;MONJE PARDO JUANCARLOS;PE脩ACOBA CASCAJARES FERNANDO LUIS. Presidente: TORRADO REVILLA JAVIER. Secretario: ARAUZO ORTEGAIGNACIO. Datos registrales. T 657, L 448, F 194, S 8, H BU 2896, I/A 19 (25.07.13).
04 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DE LA IGLESIA JAIME. Apo.Sol.: GIMENEZ PEREZ JOSE JAVIER;ARAUZO ORTEGAIGNACIO;GONZALEZ DE LA IGLESIA JAIME;ARAUZO ORTEGA IGNACIO. Apoderado: GIMENEZ PEREZ JOSE JAVIER. Apo.Sol.:GONZALEZ DE LA IGLESIA JAIME;ARAUZO ORTEGA IGNACIO;TORRADO REVILLA JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.:GONZALEZ DE LA IGLESIA JAIME;ARAUZO ORTEGA IGNACIO;TORRADO REVILLA JAVIER. Datos registrales. T 582, L 373, F25, S 8, H BU 2896, I/A 18 (27.12.12).
27 de Diciembre de 2012Nombramientos. Consejero: MONJE PARDO JUAN CARLOS. Reelecciones. Consejero: RENES DOMINGO LUIS. Presidente:RENES DOMINGO LUIS. Consejero: GONZALEZ IGLESIA JAIME. Secretario: GONZALEZ IGLESIA JAIME. Consejero: ARANDAMARTINEZ TOMAS;ARAUZO ORTEGA IGNACIO;TORRADO REVILLA JAVIER;PE脩ACOBA CASCAJARES FERNANDO.Vicesecret.: ARAUZO ORTEGA IGNACIO. Datos registrales. T 582, L 373, F 24, S 8, H BU 2896, I/A 17 (20.12.12).
20 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 90.180,00 Euros. Desembolsado: 90.180,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.300,00 Euros.Resultante Desembolsado: 150.300,00 Euros. Otros conceptos: Refundir los estatutos sociales, d谩ndoles nueva redacci贸n adaptadaa la Ley 3/2009, de 3 de abril, de sociedades de capital. Datos registrales. T 582, L 373, F 22, S 8, H BU 2896, I/A 16 (13.12.12).
08 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ARANDA MARTINEZ TOMAS. Datos registrales. T 582, L 373, F 22, S 8, H BU 2896, I/A 15(28.04.09).
28 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: CASTELLANA DE AUDITORIA Y GESTION SLP. Datos registrales. T 582, L 373, F 22, S 8, H BU 2896,I/A 14 (19.01.09).