Actos BORME de Apk Gestion De Aparcamientos Sa
13 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PIRE ABARCA FERNANDO. Nombramientos. Con.Delegado: PIRE ABARCA FERNANDO.Reelecciones. Consejero: DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO;ABELLO GAMAZO CRISTIAN PABLO;PIRE ABARCAFERNANDO.Presidente: ABELLO GAMAZO CRISTIAN PABLO. Vicepresid.: DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO. Datosregistrales. T 35768 , F 216, S 8, H M 600367, I/A 24 ( 6.09.21).
31 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE DURAN JOSE-IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: CORCUERA ALDAY NURIA. Datosregistrales. T 35768 , F 216, S 8, H M 600367, I/A 23 (23.12.20).
10 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ MORAN ALEJANDRO;VIEJO GONZALEZ DOLORES;AGUIRRE DURAN JOSE-IGNACIO;ABELLO GAMAZO CRISTIAN;DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO;PIRE ABARCA FERNANDO. Datos registrales. T35768 , F 215, S 8, H M 600367, I/A 22 ( 3.07.20).
27 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VERA MARTINEZ RAUL. Apo.Manc.: VERA MARTINEZ RAUL. Nombramientos. Apo.Manc.:ALVAREZ MORAN ALEJANDRO. Apo.Sol.: ALVAREZ MORAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 35768 , F 215, S 8, H M 600367,I/A 21 (20.09.19).
21 de Noviembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 673.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 673.048,00 Euros. Datos registrales. T 35768 , F214, S 8, H M 600367, I/A 20 (14.11.18).
05 de Junio de 2018Nombramientos. Vicepresid.: DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO. Datos registrales. T 35768 , F 214, S 8, H M 600367, I/A 19(29.05.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: ABELLO GAMAZO CRISTIAN;DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO;VERA MARTINEZ RAUL;PIREABARCA FERNANDO. Otros conceptos: REVOCACION A D.CRISTIAN ABELLO GAMAZO, D.BERNARDINO DIAZ-ANDREUGARCIA, D.FERNANDO PIRE ABARCA Y D.RAUL VERA MARTINEZ DE LA FACULTAD 1 DEL EPIGRAFE II CONFERIDA POR ELCONSEJO EL 16 DE MARZO DE 2017 EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 11. Datos registrales. T 35768 , F 213, S 8,H M 600367, I/A 18 ( 4.05.18).
25 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 10.000,00 Euros. Desembolsado: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.346.096,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.346.096,00 Euros. Datos registrales. T 35768 , F 213, S 8, H M 600367, I/A 17 (17.01.18).
18 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 10.000,00 Euros. Desembolsado: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.336.096,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.336.096,00 Euros. Datos registrales. T 35768 , F 212, S 8, H M 600367, I/A 16 (11.12.17).
30 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35768 , F 212, S 8, H M 600367, I/A 15 (20.10.17).