Actos BORME de Apolinar Fraile Sa
26 de Julio de 2019Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 51 , F 165, S 8, H SA 1501,I/A NOTA M (15.07.19).
02 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES CASCON MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 51 , F 165, S 8, H SA 1501, I/A 6(13.12.11).
20 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES CASCON MANUEL. Datos registrales. T 51 , F 165, S 8, H SA 1501, I/A 5 ( 1.12.11).
25 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ CASTELLANO DIONISIO. Presidente: CORTES CASCON MARIA DEL CARMEN. Secretario:SANCHEZ RAMOS PABLO. Consejero: DOMINGUEZ GOMEZ AGUSTIN. Con.Delegado: SANCHEZ RAMOS PABLO.Nombramientos. Consejero: GOMEZ CASTELLANO DIONISIO. Presidente: GOMEZ CASTELLANO DIONISIO. Consejero:SANCHEZ RAMOS PABLO. Secretario: SANCHEZ RAMOS PABLO. Consejero: DOMINGUEZ GOMEZ AGUSTIN;CORTES CASCONMARIA DEL CARMEN;CORTES CASCON MANUEL. Con.Delegado: SANCHEZ RAMOS PABLO. Datos registrales. T 51 , F 165, S8, H SA 1501, I/A 4 (13.05.10).