Buscador CIF Logo

Actos BORME Appnexus Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Appnexus Spain Sl

Actos BORME Appnexus Spain Sl - B86562063

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Appnexus Spain Sl con CIF B86562063

馃敊 Perfil de Appnexus Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Appnexus Spain Sl

01 de Diciembre de 2023
Otros conceptos: Subsanaci贸n de las circunstancias personales del apoderado Don David Christian Osbom, siendo lo correcto DonDavid Christian Osborn. Datos registrales. T 35271 , F 179, S 8, H M 545827, I/A 17 (24.11.23).

30 de Octubre de 2023
Nombramientos. Presidente: DOLLIVER KEITH RANGER. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 13 la publicaci贸n delnombramiento como presidente de don Keith Ranger Dolliver. Datos registrales. T 35271 , F 175, S 8, H M 545827, I/A 13 ( 8.05.23).

Revocaciones. Apoderado: BORNOR DAVID. Nombramientos. Apoderado: OSBOM DAVID-CHRISTIAN. Datos registrales. T35271 , F 178, S 8, H M 545827, I/A 16 (23.10.23).

17 de Agosto de 2023
Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 35271 , F 178, S 8, H M545827, I/A 15 ( 9.08.23).

16 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BASTOW MARK DAVID;UNDERHILL JEROME JOHN;BOUDARD REMI. Nombramientos.Consejero: DOLLIVER KEITH RANGER;ORNDORFF BENJAMIN OWEN;KIVIAT LEIGH ANNE. SecreNoConsj: GONZALEZ ESPEJOGARCIA PABLO. Modificaciones estatutarias. REFUNDICION ESTATUTOS. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. PASEO CLUBDEPORTIVO 1 - PARQUE EMPRESARIAL LA FIN (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 35271 , F 175, S 8, H M 545827,I/A 13 ( 8.05.23).

Revocaciones. Apoderado: ESCRIVA DE ROMANI MORALES-ARCE IGNACIO;ALVAREZ FREIJEIRO ANA;PARK SHINSORA;CORONEL DE PALMA DE LA MATA ALFONSO ENRIQUE;VILLASMIL BOLINAGA LUIS IGNACIO;LUCENA REBOLLOALVARO;BASTOW MARK DAVID;UNDERHILL JEROME JOHN;BOUDARD REMI. Datos registrales. T 35271 , F 178, S 8, H M545827, I/A 14 ( 8.05.23).

17 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: PEREZ RANEDO EDUARDO;NORIEGA GARCIA MIGUEL;LLANOS ALPERI JOSEMANUEL;BIDAGUREN URBIETA MIREN. Apo.Sol.: DAS NITHYA;DVORKIN MICHELLE;BORNOR DAVID;O'KELLEY CHARLESBRIAN;RUBENSTEIN MICHAEL EVAN. Apoderado: HEINRICHS KRISTOPHER MICHAEL;DAS NITHYA;HSU JONATHAN KEVIN.Nombramientos. Apoderado: BORNOR DAVID;ALVAREZ FREIJEIRO ANA;PARK SHIN SORA;CORONEL DE PALMA DE LA MATAALFONSO ENRIQUE;VILLASMIL BOLINAGA LUIS IGNACIO;LUCENA REBOLLO ALVARO;BASTOW MARK DAVID;UNDERHILLJEROME JOHN;BOUDARD REMI. Datos registrales. T 35271 , F 171, S 8, H M 545827, I/A 12 (10.03.22).

13 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: O'KELLEY CHARLES BRIAN;RUBENSTEIN MICHAEL EVAN. Nombramientos. Adm.Mancom.: BASTOW MARK DAVID;UNDERHILL JEROME JOHN;BOUDARD REMI. Modificaciones estatutarias. Se modifica elart铆culo 6潞 de los Estatutos Sociales relativo a los modos de organizar la administraci贸n. Datos registrales. T 35271 , F 170, S 8, H M545827, I/A 11 ( 6.07.21).

24 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. PASEO RECOLETOS 27 (MADRID). Datos registrales. T 35271 , F 170, S 8, H M 545827, I/A 10(17.11.20).

12 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ DEL PINAR 5 - SUITE 401 (MADRID). Datos registrales. T 35271 , F 170, S 8, H M 545827, I/A 9 (2.02.18).

26 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: HEINRICHS KRISTOPHER MICHAEL;DAS NITHYA;HSU JONATHAN KEVIN. Datos registrales. T30323 , F 155, S 8, H M 545827, I/A 8 (19.09.17).

07 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BRANCA ANTHONY JOSEPH. Nombramientos. Apo.Sol.: O'KELLEY CHARLES BRIAN;RUBENSTEINMICHAEL EVAN. Datos registrales. T 30323 , F 153, S 8, H M 545827, I/A 7 (28.04.15).

05 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: COOPERMAN BRUCE. Nombramientos. Apo.Sol.: BRANCA ANTHONY JOSEPH;DASNITHYA;DVORKIN MICHELLE;BORNOR DAVID. Datos registrales. T 30323 , F 152, S 8, H M 545827, I/A 6 (25.02.14).

07 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: COOPERMAN BRUCE. Datos registrales. T 30323 , F 151, S 8, H M 545827, I/A 5 (25.04.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n