Buscador CIF Logo

Actos BORME Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl

Actos BORME Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl - B81211278

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl con CIF B81211278

🔙 Perfil de Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aptiva Consultores De Recursos Humanos Sl

16 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: BERROCAL VELASCO ARACELI;BERROCAL VELASCO ARACELI. Nombramientos. Apo.Sol.:CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO. Datos registrales. T 18327 , F 172, S 8, H M 155368, I/A 33 ( 9.03.23).

07 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: CAMPS GUERRERO JOSE MARIA;CAMPS GUERRERO JOSE MARIA. Cambio de domicilio social.C/ LUCHANA 23 3º (MADRID). Datos registrales. T 18327 , F 172, S 8, H M 155368, I/A 32 (31.01.23).

25 de Febrero de 2022
Ampliación de capital. Capital: 300.494,94 Euros. Resultante Suscrito: 303.500,00 Euros. Otros conceptos: ELVACION DELVALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE COMPONEN EL CAPITAL SOCIAL, QUE PASA DE6,010121 EUROS A 607 EUROS. Datos registrales. T 18327 , F 172, S 8, H M 155368, I/A 31 (18.02.22).

03 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: FONSECA MAGANTO PILAR;MUÑIZ GARCIA LUIS;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;GUTIERREZGARCIA CRISTINA;BELIEN NADINE LODEWIJK MARTHA. Datos registrales. T 18327 , F 171, S 8, H M 155368, I/A 29 (26.11.21).

Nombramientos. Apoderado: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Datos registrales. T 18327 , F 171, S 8, H M 155368, I/A 30(26.11.21).

28 de Junio de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: THEEBOOM-CREYF MARIANNE GABRIELLE. Ceses/Dimisiones.SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Representan: THEEBOOM-CREYF MARIANNE GABRIELLE. Consejero:CREYF HERMAN HARRY PETER;AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Presidente:THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Nombramientos. Adm.Unico: THEEBOOM-CREYF MARIANNE GABRIELLE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 18327 , F 171, S 8, H M 155368, I/A 28 (21.06.19).

31 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO. Datos registrales. T 18327 , F 170, S 8, H M 155368,I/A 27 (23.10.17).

17 de Abril de 2017
Reelecciones. Representan: THEEBOOM-CREYF MARIANNE GABRIELLE. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGARCARLOS. Consejero: CREYF HERMAN HARRY PETER;AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNEGABRIELLE. Presidente: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Con.Delegado: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE.Datos registrales. T 18327 , F 170, S 8, H M 155368, I/A 26 ( 5.04.17).

07 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. GTA DE QUEVEDO 9 3º(MADRID). Datos registrales. T 18327 , F 169, S 8, H M 155368, I/A 25 (30.03.16).

24 de Abril de 2014
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 18327 , F 169, S 8, H M 155368, I/A 24(14.04.14).

02 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO. Datos registrales. T 18327 , F 169, S 8, H M 155368,I/A 23 (25.03.14).

14 de Enero de 2013
Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 37 8 (MADRID). Datos registrales. T 18327 , F 168, S 8, H M 155368, I/A 22 (3.01.13).

31 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: CAMPS GUERRERO JOSE MARIA. Secretario: AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA.Cons.Del.Sol: AGIO SERVICIOS CENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Nombramientos.Representan: THEEBOOM-CREYF MARIANNE GABRIELLE. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Con.Delegado:THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Reelecciones. Consejero: CREYF HERMAN HARRY PETER;AGIO SERVICIOSCENTRALIZADOS SA;THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Presidente: THEBOOM CREYF MARIANNE GABRIELLE. Datosregistrales. T 18327 , F 167, S 8, H M 155368, I/A 20 (20.07.12).

Revocaciones. Apoderado: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;LASAGA GILADOLORES ANGELES;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA. Nombramientos. Apoderado: BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINADE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERRERO JOSE MARIA;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;RODRIGUEZ SANCHEZANGEL LUIS;BERROCAL VELASCO ARACELI;CORTINA DE LA HERRAN JULIAN EDUARDO;CAMPS GUERRERO JOSEMARIA;GUTIERREZ GARCIA CRISTINA;BELIEN NADINE LODEWIJK MARTHA. Datos registrales. T 18327 , F 168, S 8, H M155368, I/A 21 (20.07.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información