Actos BORME de Aquacartaya Sociedad Limitada
24 de Enero de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5848 , F 140, S 8, H SE 98784, I/A 20 (15.01.18).
15 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Extendida nota marginal conforme al Art. 231 del R.R.M., no existen obst谩culos para la FUSION PORABSORCION de la sociedad AQUACARTAYA SL, que ser谩 ABSORBIDA por la denominada "FCC AQUALIA, S.A.", domiciliada enMadrid, C.I.F A26019992. Datos registrales. T 5848 , F 140, S 8, H SE 98784, I/A 19 2 ( 5.12.17).
21 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORALES LOPEZ GABRIEL. Datos registrales. T 5848 , F 140, S 8, H SE 98784, I/A 19 (14.07.17).
30 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 5848 , F 139, S 8, H SE 98784, I/A 18(23.06.17).
14 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: CRESPO GARZON ALBERTO. Datos registrales. T 5848 , F 138, S 8, H SE 98784, I/A 17 ( 7.03.17).
11 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 5848 , F 138, S 8, H SE 98784, I/A 16 (27.11.15).
05 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 5848 , F 135, S 8, H SE 98784, I/A 15(27.10.15).
08 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DE LOS RIOS JIMENO JUAN. Datos registrales. T 5848 , F 135, S 8, H SE 98784, I/A 14(27.03.15).
10 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTIAGO BARRAJON MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 5848 , F 134, S 8, H SE 98784,I/A 13 ( 2.12.14).
29 de Julio de 2014Fe de erratas: RECTIFICADA la anterior inscripci贸n 5&, envio 133 del B.O.R.M.E. de fecha 16.7.2014, en el sentido de que el primerapellido del apoderado es "NICOLA", y no "NICOLAS".- Datos registrales. T 5848 , F 134, S 8, H SE 98784, I/A 12 (18.07.14).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: NICOLAS GARCIA ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 5848 , F 123, S 8, H SE 98784, I/A 5 (1.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Datos registrales. T 5848 , F 125, S 8, H SE 98784, I/A 6 ( 1.07.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: AMOR MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5848 , F 128, S 8, H SE 98784, I/A 7 (1.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES LOPEZ GABRIEL. Datos registrales. T 5848 , F 128, S 8, H SE 98784, I/A 8 ( 1.07.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALCOUCER DIAZ MANUEL. Datos registrales. T 5848 , F 130, S 8, H SE 98784, I/A 9 ( 1.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLALOBOS LINARES FRANCISCO. Datos registrales. T 5848 , F 130, S 8, H SE 98784, I/A 10 (1.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ MATEOS MONTSERRAT. Datos registrales. T 5848 , F 132, S 8, H SE 98784, I/A 11( 1.07.14).
12 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Nombramientos. Consejero: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Presidente: DIAZGAZQUEZ LUCAS. Consejero: VILLALOBOS LINARES FRANCISCO. Vicepresid.: VILLALOBOS LINARES FRANCISCO. Consejero:LOPEZ BARRANCO CRISTINA. Secretario: LOPEZ BARRANCO CRISTINA. VsecrNoConsj: DE LOS RIOS JIMENO JUAN.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otrosconceptos: DETERMINADO EN TRES EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T5757 , F 98, S 8, H SE 98784, I/A 2 (24.04.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 5757 , F 99, S 8, H SE 98784, I/A 3 (24.04.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 5757 , F 102, S 8, H SE 98784, I/A 4(24.04.14).
23 de Octubre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.10.13. Objeto social: La captaci贸n transporte, tratamiento y distribuci贸n de agua, conc贸digo CNAE 2009 n煤mero 3600, que inicialmente ser谩 su actividad principal. Domicilio: AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 15(SEVILLA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Datos registrales. T 5757 , F 97, S 8,H SE 98784, I/A 1 (16.10.13).