Buscador CIF Logo

Actos BORME Aquapark Internacional Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aquapark Internacional Sa

Actos BORME Aquapark Internacional Sa - A29093341

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aquapark Internacional Sa con CIF A29093341

🔙 Perfil de Aquapark Internacional Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aquapark Internacional Sa

18 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 134, S 8, H M 70694, I/A 79 (11.12.23).

03 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 133, S 8, H M 70694, I/A 78 (27.12.22).

30 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: LARIOS BRUNA JORGE;GARDE GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 30912 , F 132, S 8, H M 70694,I/A 77 (23.06.22).

16 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 132, S 8, H M 70694, I/A 76 ( 8.11.21).

22 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 132, S 8, H M 70694, I/A 75 (12.03.21).

28 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 132, S 8, H M 70694, I/A 74 (21.02.20).

16 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GARCIA COHEN BRUNO;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;HERRERA TORRALBOEMILIO;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Apo.Manc.: GONZALEZFERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LARIOS BRUNA JORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES;GARCIACOHEN BRUNO. Datos registrales. T 30912 , F 25, S 8, H M 70694, I/A 73 ( 5.12.19).

28 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LOPEZ SORIANODAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Secretario: GONZALEZFERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Cons.Del.Man: LOPEZ SORIANO DAVID;GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Vicepresid.:LOPEZ SORIANO DAVID. Nombramientos. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Presidente: SMITH MORRONDOJUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Consejero: LOPEZ SORIANO DAVID. Vicepresid.: LOPEZSORIANO DAVID. Cons.Del.Man: LOPEZ SORIANO DAVID. Consejero: GARDE GARCIA JAVIER. Secretario: GARDE GARCIAJAVIER. Cons.Del.Man: GARDE GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 30912 , F 25, S 8, H M 70694, I/A 72 (21.10.19).

29 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ SANCHEZ DAVID. Apo.Manc.: GARCIA COHEN BRUNO;LARIOS BRUNAJORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 30912 , F 24, S 8, H M 70694, I/A 71(22.03.19).

05 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 24, S 8, H M 70694, I/A 70 (26.02.19).

14 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 23, S 8, H M 70694, I/A 69 ( 3.09.18).

27 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;HERRERATORRALBO EMILIO;HERRERA TORRALBO EMILIO. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN.Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LARIOS BRUNA JORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOSANGELES. Vicepresid.: LOPEZ SORIANO DAVID. Apo.Manc.: GARCIA COHEN BRUNO. Datos registrales. T 30912 , F 22, S 8, HM 70694, I/A 68 (19.03.18).

20 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE RAMON-LACA COTORRUELO JESUS. Secretario: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS.Con.Delegado: JESUS DE RAMON LACA COTORRUELO. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZFERNANDEZ PINEDO JULIAN;SORIANO LOPEZ DAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: SORIANOLOPEZ DAVID. Vicesecret.: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Con.Delegado: SMITH MORRONDO JUANCARLOS;SORIANO LOPEZ DAVID. Nombramientos. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LOPEZ SORIANO DAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDOJUAN CARLOS. Secretario: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Cons.Del.Man: LOPEZ SORIANO DAVID;GONZALEZFERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 30912 , F 22, S 8, H M 70694, I/A 67 (12.02.18).

17 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apoderado: LOBEJON GONZALEZ ADOLFO;LOBEJON GONZALEZ ADOLFO. Nombramientos. Apo.Sol.: LARIOSBRUNA JORGE. Apo.Manc.: LARIOS BRUNA JORGE;LOPEZ SORIANO DAVID;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 30912 , F 20, S 8, H M 70694, I/A 66 ( 6.10.17).

12 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: HERRERA TORRALBO EMILIO. Apo.Manc.: HERRERA TORRALBO EMILIO;MULET SOLONCATERINA;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Nombramientos. Apoderado: HERRERA TORRALBO EMILIO;HERRERATORRALBO EMILIO;GARCIA COHEN BRUNO;LOPEZ SORIANO DAVID;LOBEJON GONZALEZ ADOLFO;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 30912 , F 19, S 8, H M 70694, I/A 65 ( 4.04.17).

03 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: BALLESTER SAAVEDRA FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: GARDE GARCIA JAVIER.Datos registrales. T 30912 , F 19, S 8, H M 70694, I/A 64 (26.01.17).

03 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 19, S 8, H M 70694, I/A 63 (24.10.16).

06 de Mayo de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 62& EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO,VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LOPEZ SORIANO DAVID, SIENDO LO CORRECTO SORIANO LOPEZ DAVID.Datos registrales. T 30912 , F 18, S 8, H M 70694, I/A 62 (12.01.16).

20 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;BARRACHINA MORENO ANGEL. Cons.Del.Sol: SMITHMORRONDO JUAN CARLOS. Consejero: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS. Secretario: DE RAMON LACA COTORRUELOJESUS. Presidente: BARRACHINA MORENO ANGEL. Vicepresid.: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Nombramientos.Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;DE RAMON-LACA COTORRUELO JESUS;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;LOPEZ SORIANO DAVID. Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Secretario: DE RAMON LACA COTORRUELOJESUS. Vicepresid.: LOPEZ SORIANO DAVID. Vicesecret.: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Con.Delegado: SMITHMORRONDO JUAN CARLOS;JESUS DE RAMON LACA COTORRUELO;LOPEZ SORIANO DAVID. Datos registrales. T 30912 , F18, S 8, H M 70694, I/A 62 (12.01.16).

23 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 18, S 8, H M 70694, I/A 61 (16.09.15).

24 de Junio de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 17, S 8, H M 70694, I/A 60 (17.06.15).

18 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: MULET SOLON CATERINA;MULET SOLON CATERINA. Datos registrales. T 30912 , F 17, S 8, H M70694, I/A 59 (10.03.15).

24 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTIN OLMEDO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 30912 , F 17, S 8, H M 70694, I/A 58(17.02.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERRERA TORRALBO EMILIO. Nombramientos. Apoderado: HERRERA TORRALBO EMILIO.Apo.Manc.: HERRERA TORRALBO EMILIO;MULET SOLON CATERINA;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datosregistrales. T 30912 , F 16, S 8, H M 70694, I/A 57 (17.02.14).

18 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30912 , F 16, S 8, H M 70694, I/A 56 (10.12.13).

02 de Julio de 2013
Nombramientos. Apoderado: MULET SOLON CATERINA;MULET SOLON CATERINA;HERRERA TORRALBO EMILIO;GONZALEZFERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 30912 , F 15, S 8, H M 70694, I/A 55 (24.06.13).

01 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERRERA TORRALBO EMILIO. Apo.Manc.: MARTIN OLMEDO JOSE MANUEL;GONZALEZFERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 16070 , F 209, S 8, H M 70694, I/A 54 (20.03.13).

22 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARRACHINA MORENO ANGEL. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN.Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;LOBEJONGONZALEZ ADOLFO;VILLAESCUSA GARCIA QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 16070 , F 208, S 8, H M70694, I/A 53 ( 9.10.12).

23 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16070 , F 208, S 8, H M 70694, I/A 52 ( 9.08.12).

26 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: BALLESTER SAAVEDRA FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: SMITH MORRONDO JUANCARLOS;BARRACHINA MORENO ANGEL. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Consejero: DE RAMON LACACOTORRUELO JESUS. Secretario: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS. Presidente: BARRACHINA MORENO ANGEL.Vicepresid.: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 16070 , F 207, S 8, H M 70694, I/A 51 (16.07.12).

20 de Junio de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16070 , F 207, S 8, H M 70694, I/A 50 ( 9.06.11).

02 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16070 , F 207, S 8, H M 70694, I/A 49 (18.11.10).

24 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16070 , F 207, S 8, H M 70694, I/A 48 (15.12.09).

05 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 16070 , F 206, S 8, H M 70694, I/A47 (23.02.09).

22 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16070 , F 206, S 8, H M 70694, I/A 46 (13.01.09).

07 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: MARINA BARRIO CARLOS. Apo.Sol.: MARINA BARRIO CARLOS. Datos registrales. T 16070 , F 206,S 8, H M 70694, I/A 45 (22.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información