Actos BORME de Arafre Sa
20 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 33633 , F 69, S 8, H M 44855, I/A 36 (13.12.23).
29 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 33633 , F 69, S 8, H M 44855, I/A 35 (22.01.21).
17 de Marzo de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 906.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.437.500,00 Euros. Datos registrales. T 33633 ,F 68, S 8, H M 44855, I/A 34 (10.03.20).
16 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL;ARANGURENDIEZ ALFREDO;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Secretario: SANCHEZ-BERNUYFERNANDEZ RIESCO ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;ARANGUREN DIEZ ALFREDO;POLO ESTEBANJUAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCOANGEL;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL;AURIGA GESTIONES SL. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Secretario:SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ-BERNUYFERNANDEZ RIESCO ANGEL;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL;AURIGA GESTIONES SL. Representan: ARANGUREN DIEZ
18 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 33633 , F 67, S 8, H M 44855, I/A 32 ( 9.01.18).
26 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Datos registrales. T 33633 , F 66, S 8, H M 44855, I/A 31 (19.05.17).
05 de Febrero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 781.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.343.750,00 Euros. Datos registrales. T 33633 ,F 65, S 8, H M 44855, I/A 30 (29.01.16).
20 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Consejero:SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL. Secretario: SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL. Consejero:POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCOANGEL;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Consejero: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Cons.Del.Sol: ARANGUREN DIEZ ALFREDO.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ-BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL;ARANGURENDIEZ ALFREDO;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Secretario: SANCHEZ-BERNUYFERNANDEZ RIESCO ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;ARANGUREN DIEZ ALFREDO;POLO ESTEBANJUAN MANUEL. Datos registrales. T 2573 , F 94, S 8, H M 44855, I/A 29 (12.08.15).
09 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 2573 , F 94, S 8, H M 44855, I/A 28 (27.02.15).
06 de Marzo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 631.325,62 Euros. Resultante Suscrito: 3.125.000,00 Euros. Datos registrales. T 2573 , F92, S 8, H M 44855, I/A 27 (25.02.15).
05 de Diciembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 390.657,85 Euros. Desembolsado: 390.657,85 Euros. Resultante Suscrito: 3.756.325,62 Euros.Resultante Desembolsado: 3.756.325,62 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social.Datos registrales. T 2573 , F 92, S 8, H M 44855, I/A 26 (27.11.13).
16 de Octubre de 2012Cambio de domicilio social. AVDA VENTISQUERO DE LA CONDESA 50 (MADRID). Datos registrales. T 2573 , F 92, S 8, H M44855, I/A 25 ( 3.10.12).
26 de Abril de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 360.607,26 Euros. Desembolsado: 360.607,26 Euros. Resultante Suscrito: 3.365.667,77 Euros.Resultante Desembolsado: 3.365.667,77 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 2573 , F 91, S 8, H M 44855, I/A 24 (16.04.12).
16 de Febrero de 2012Nombramientos. Consejero: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Cons.Del.Sol: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Datos registrales. T2573 , F 91, S 8, H M 44855, I/A 23 ( 7.02.12).
14 de Diciembre de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.081.821,78 Euros. Datos registrales. T 2573 , F 90, S 8, H M 44855, I/A 22(29.11.11).
31 de Octubre de 2011Nombramientos. Cons.Del.Sol: MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Fe de erratas: SEOMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 18& EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJEROS DELEGADOS SOLIDARIOS DEMATEO CERRADA ANTONIO FERMIN Y POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2573 , F 88, S 8, H M 44855, I/A 18( 1.04.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN. Cons.Del.Sol: MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN.Datos registrales. T 2573 , F 90, S 8, H M 44855, I/A 21 (20.10.11).
24 de Octubre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.163.643,56 Euros. Desembolsado: 1.081.821,78 Euros. Resultante Suscrito: 3.005.060,51 Euros.Resultante Desembolsado: 1.923.238,73 Euros. Datos registrales. T 2573 , F 89, S 8, H M 44855, I/A 20 (11.10.11).
06 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: FRECHILLA SANTAMARIA TOMAS. Datos registrales. T 2573 , F 89, S 8, H M 44855, I/A 19(24.06.11).
13 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NAVARRO RUBIO JOSE JOAQUIN. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Presidente:RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Consejero: FERMIN-MATEO CERRADA ANTONIO;SANCHEZ BERNUY FERNANDEZ RIESCOANGEL;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Con.Delegado: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Nombramientos. Consejero:RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Consejero: SANCHEZ BERNUY FERNANDEZRIESCO ANGEL. Secretario: SANCHEZ BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL. Consejero: MATEO CERRADA ANTONIOFERMIN;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO;SANCHEZ BERNUY FERNANDEZRIESCO ANGEL. Datos registrales. T 2573 , F 88, S 8, H M 44855, I/A 18 ( 1.04.11).
12 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Consejero: MATEOCERRADA ANTONIO FERMIN;FRECHILLA SANTAMARIA TOMAS;SANCHEZ BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL;POLOESTEBAN JUAN MANUEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Secretario: NAVARRO RUBIO JOSE JOAQUIN.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Presidente: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Consejero: FERMIN-MATEO CERRADA ANTONIO;SANCHEZ BERNUY FERNANDEZ RIESCO ANGEL;POLO ESTEBAN JUAN MANUEL. SecreNoConsj:NAVARRO RUBIO JOSE JOAQUIN. Con.Delegado: RODRIGUEZ TORRES ARTURO. Datos registrales. T 2573 , F 88, S 8, H M44855, I/A 17 (31.03.11).
08 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: PONSATI OJEDA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2573 , F 88, S 8, H M 44855, I/A 16 (26.05.10).
18 de Junio de 2009Nombramientos. Auditor: GOMEZ OTERO ARSENIO. Datos registrales. T 2573 , F 88, S 8, H M 44855, I/A 15 ( 8.06.09).