Actos BORME de Aragonesa De Componentes Pasivos Sa
13 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: CONTROLPLAN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4145 , F 74, S 8, H Z 1059, I/A 40 ( 1.12.21).
05 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CASCAN GRAVALOS SANTIAGO. Reelecciones. Consejero: MERCADAL MAIRALFERNANDO;JIMENEZ DELGADO ERNESTO;ORTIZ DELGADO LUIS-JOSE. Presidente: MERCADAL MAIRAL FERNANDO.Secretario: JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Datos registrales. T 4145 , F 73, S 8, H Z 1059, I/A 39 (28.10.20).
04 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4145 , F 73, S 8, H Z 1059, I/A17 (27.06.18).
25 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MERCADAL MAIRAL FERNANDO;JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Datos registrales. T 4145 , F 73, S8, H Z 1059, I/A 37 (18.05.17).
14 de Marzo de 2016Reducción de capital. Importe reducción: 247.136,18 Euros. Resultante Suscrito: 1.099.130,93 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo 12º.- Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo deAdministración, mediante anuncio en la página web corporativa de la sociedad www.acptechnologies.com, con una antelación mínimade treinta días antes de la fecha fijada para su Artículo 18º.- El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible. LosConsejeros desempeñarán su cargo por un plazo de cinco años y podrán ser reelegidos una o más veces, por iguales periodos detiempo. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran vacantes, el Consejo. Página web de la sociedad. Creaciónde la página web corporativa: www.acptechnologies.com. Datos registrales. T 2766 , F 111, S 8, H Z 1059, I/A 18 ( 4.03.16).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2766 , F 111, S 8, H Z 1059,I/A 17 ( 9.02.16).
25 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BELTRAN PICAPEO ARTURO. Presidente: BELTRAN PICAPEO ARTURO. Consejero: MERCADALMAIRAL FERNANDO. Vicepresid.: MERCADAL MAIRAL FERNANDO. Consejero: JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Secretario:JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Revocaciones. Apoderado: MERCADAL MAIRAL FERNANDO;PINEDA CUDOSRAFAEL;JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Nombramientos. Consejero: MERCADAL MAIRAL FERNANDO. Presidente: MERCADALMAIRAL FERNANDO. Consejero: JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Secretario: JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Consejero: CASCANGRAVALOS SANTIAGO;ORTIZ DELGADO LUIS-JOSE. Apo.Sol.: MERCADAL MAIRAL FERNANDO;JIMENEZ DELGADOERNESTO. Datos registrales. T 2766 , F 110, S 8, H Z 1059, I/A 34 (17.02.15).
05 de Noviembre de 2014Nombramientos. Aud.Supl.: CIVERA ESCORIHUELA PEDRO. Reelecciones. Auditor: SANCHEZ LAZARO FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 2766 , F 110, S 8, H Z 1059, I/A 33 (27.10.14).
07 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: SANCHEZ LAZARO FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: LAZARO GALAN LUIS. Datos registrales. T 2766 , F110, S 8, H Z 1059, I/A 32 (23.12.13).
11 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: SANCHEZ LAZARO FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: LAZARO GALAN LUIS. Datos registrales. T 2766 , F110, S 8, H Z 1059, I/A 31 ( 3.04.13).
01 de Septiembre de 2009Reelecciones. Consejero: BELTRAN PICAPEO ARTURO. Presidente: BELTRAN PICAPEO ARTURO. Consejero: MERCADALMAIRAL FERNANDO. Vicepresid.: MERCADAL MAIRAL FERNANDO. Consejero: JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Secretario:JIMENEZ DELGADO ERNESTO. Datos registrales. T 2766 , F 109, S 8, H Z 1059, I/A 29 (20.08.09).
Nombramientos. Aud.Supl.: LAZARO GALAN LUIS. Reelecciones. Auditor: SANCHEZ LAZARO FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.:LAZARO GALAN LUIS. Auditor: SANCHEZ LAZARO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2766 , F 110, S 8, H Z 1059, I/A 30(20.08.09).