Buscador CIF Logo

Actos BORME Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl

Actos BORME Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl - B25542572

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Lleida para Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl con CIF B25542572

🔙 Perfil de Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Lleida

Actos BORME de Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats Sl

25 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SLP. Datos registrales. T 860 , F 215, S 8, H L 16614, I/A 23 (17.01.22).

07 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apoderado: GRAU MORA XAVIER. Apo.Manc.: GRAU MORA XAVIER. Datos registrales. T 860 , F 215, S 8, H L16614, I/A 21 (30.09.21).

Nombramientos. Apoderado: VILANA GONZALEZ JORDI. Datos registrales. T 860 , F 215, S 8, H L 16614, I/A 22 (30.09.21).

04 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: GRAU MORA XAVIER. Nombramientos. D. Gerente: VILANA GONZALEZ JORDI. Datosregistrales. T 860 , F 215, S 8, H L 16614, I/A 20 (24.09.21).

08 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOYA ALOS FRANCESC XAVIER. Presidente: BOYA ALOS FRANCESC XAVIER. Nombramientos.Consejero: SERRANO IGLESIAS JUAN ANTONIO. Presidente: VERGES PEREZ MARIA. Datos registrales. T 860 , F 131, S 8, H L16614, I/A 18 (28.01.21).

Nombramientos. Apoderado: GRAU MORA XAVIER. Datos registrales. T 860 , F 214, S 8, H L 16614, I/A 19 (28.01.21).

31 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SLP. Datos registrales. T 860 , F 131, S 8, H L 16614, I/A 17 (21.12.20).

02 de Junio de 2020
Otros conceptos: Quedar refundidos la totalidad de los estatutos sociales de la sociedad. Datos registrales. T 860 , F 13, S 8, H L16614, I/A 14 (22.05.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRERA SANCHEZ CARLOS;DIAZ MORELLO ANNA;BORRAS HURTADO MARIAANGELES;VERGES PEREZ MARIA;BOYA QUINTANA JOSE ANTONIO. D. Gerente: GRAU MORA XAVIER. Presidente: BARRERASANCHEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: BOYA ALOS FRANCESC XAVIER;VERGES PEREZ MARIA;BRUNA CAPELFRANCISCO;RUIZ-CANELA NIETO CESAR;BORRAS HURTADO MARIA ANGELES. Presidente: BOYA ALOS FRANCESC XAVIER.D. Gerente: GRAU MORA XAVIER. Otros conceptos: Queda nombrada/ratificada doña Núria Escobar Serra, como Secretaria delConsejo de Administración de la sociedad. Datos registrales. T 860 , F 130, S 8, H L 16614, I/A 15 (22.05.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: GRAU MORA XAVIER;BORRAS HURTADO MARIA ANGELES;GARCIA RIVAS MARINO. Datosregistrales. T 860 , F 130, S 8, H L 16614, I/A 16 (26.05.20).

08 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MONTALA PALAU DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: ESCOBAR SERRA NURIA. Datosregistrales. T 860 , F 13, S 8, H L 16614, I/A 12 ( 1.03.18).

Nombramientos. Auditor: PROAUDIT SLP. Datos registrales. T 860 , F 13, S 8, H L 16614, I/A 13 ( 1.03.18).

02 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: BARRERA SANCHEZ CARLOS. Consejero: BARRERA SANCHEZ CARLOS;DIAZ MORELLOANNA;BOYA ALOS FRANCESC;BORRAS HURTADO MARIA ANGELES;VALDECANTOS DEDIU EDUARDO. Dir. General: GRAUMORA XAVIER. SecreNoConsj: ESCOBAR SERRA NURIA. Nombramientos. Consejero: BARRERA SANCHEZ CARLOS;BOYAQUINTANA JOSE ANTONIO;DIAZ MORELLO ANNA;VERGES PEREZ MARIA;BORRAS HURTADO MARIA ANGELES. D. Gerente:GRAU MORA XAVIER. SecreNoConsj: MONTALA PALAU DAVID. Presidente: BARRERA SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T860 , F 12, S 8, H L 16614, I/A 11 (22.02.16).

11 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ GOMEZ RICARD. Nombramientos. SecreNoConsj: ESCOBAR SERRA NURIA.Datos registrales. T 860 , F 11, S 8, H L 16614, I/A 10 (29.10.15).

17 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 860 , F 11, S 8, H L 16614, I/A 9 ( 9.12.14).

22 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: BORRAS HURTADO MARIA ANGELES;FERNANDEZ ENRICH FRANCESC;SANCHEZ FARREARTUR. Presidente: BOYA ALOS FRANCESC. Consejero: BOYA ALOS FRANCESC;COSTA RIU NOELIA. Nombramientos.Consejero: BARRERA SANCHEZ CARLOS;DIAZ MORELLO ANNA;BOYA ALOS FRANCESC;BORRAS HURTADO MARIAANGELES;VALDECANTOS DEDIU EDUARDO. Presidente: BARRERA SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T 860 , F 10, S 8, HL 16614, I/A 7 (13.09.11).

Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 860 , F 11, S 8, H L 16614, I/A 8 (13.09.11).

09 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: FERNANDEZ ENRICH FRANCESC. Nombramientos. Dir. General: GRAU MORA XAVIER. Datosregistrales. T 860 , F 10, S 8, H L 16614, I/A 6 ( 1.06.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información