Buscador CIF Logo

Actos BORME Araven Group Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Araven Group Sl

Actos BORME Araven Group Sl - B87705323

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Araven Group Sl con CIF B87705323

馃敊 Perfil de Araven Group Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Araven Group Sl

27 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAYOLO BANDERA NOEL. Datos registrales. T 35760 , F 117, S 8, H M 639450, I/A 27 (20.10.23).

18 de Agosto de 2023
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 35760 , F 117, S 8, H M 639450, I/A 26 (10.08.23).

03 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: BERNARDINO MARTIN MANUELA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES DIAZ LAURA. Datosregistrales. T 35760 , F 116, S 8, H M 639450, I/A 25 (24.04.23).

17 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35760 , F 116, S 8, H M 639450, I/A 24 (10.11.22).

18 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: ANDUJAR LOZANO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 35760 , F 116, S 8, H M 639450, I/A 23(10.10.22).

06 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDUJAR LOZANO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMIREZ TOCINOCRISTINA;BADAJOZ ANDRES ALBERTO;DE ANDRES GONZALEZ JAVIER;MARTINEZ ASTUDILLO JORGE;OLMEDO TORRESVICENTE JAVIER. Datos registrales. T 35760 , F 113, S 8, H M 639450, I/A 22 (29.06.22).

19 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLEDO POZAS MANUEL. Nombramientos. Consejero: ELORDI IZCOA KERMAN. Datosregistrales. T 35760 , F 113, S 8, H M 639450, I/A 21 (11.05.22).

28 de Junio de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 68.788,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.365.846,00 Euros. Datos registrales. T 35760 , F112, S 8, H M 639450, I/A 20 (21.06.21).

16 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ANDRES GONZALEZ JAVIER;MARTINEZ ASTUDILLO JORGE;ANDUJAR LOZANO JUANANTONIO;OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER;RAMIREZ TOCINO CRISTINA;BERNARDINO MARTIN MANUELA. Datosregistrales. T 35760 , F 110, S 8, H M 639450, I/A 19 ( 9.02.21).

08 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANOVA ABADIA JAVIER;SEBASTIAN MANZANARES ALFONSO. Revocaciones. Apoderado:VILLANOVA ABADIA JAVIER;SEBASTIAN MANZANARES ALFONSO. Nombramientos. Consejero: BONO GUERREROJOSEP;BLAS ZUDAIRE SAROBE JOSE MIGUEL. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35760 , F109, S 8, H M 639450, I/A 18 ( 1.02.21).

20 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: DE ANDRES GONZALEZ JAVIER;VILLANOVA ABADIA JAVIER;SEBASTIAN MANZANARESALFONSO;ANDUJAR LOZANO JUAN ANTONIO;OLMEDO TORRES VICENTE JAVIER;RAMIREZ TOCINO CRISTINA;BERNARDINOMARTIN MANUELA. Otros conceptos: REVOCACION DE LOS PODERES MANCOMUNADOS CONFERIDOS A DON VICENTEJAVIER OLMEDO TORRES. Datos registrales. T 35760 , F 107, S 8, H M 639450, I/A 17 (13.07.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n