Actos BORME de Arbegui Sociedad Anonima
06 de Mayo de 2022Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ARBEGUI PATRIMONIAL SOCIEDAD LIMITADA. ARBEGUITRANSPORTES ESPECIALES SOCIEDAD LIMITADA. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 1187 , F 118, S 8, HBI 2235,A , I/ 43 .(25.04.22).
26 de Septiembre de 2019Reelecciones. Consejero: BILBAO ARZADUN JULEN;BERGE ARZADUN MARTA;ARZADUN LARRUCEA MARIA. Presidente:BILBAO ARZADUN JULEN. Secretario: BERGE ARZADUN MARTA. Datos registrales. T 1187 , F 117, S 8, H BI 2235,A , I/ 42.(19.09.19).
15 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: ARZADUN LARRUCEA JULEN;GONZALEZ MONTOYA BLANCA MARIA. Apoderado: URIBARRIECHEBARRIA GOTZON. Datos registrales. T 1187 , F 117, S 8, H BI 2235,A , I/ 41 .( 6.03.17).
05 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: TSORBA FRANCK DIMITRI. Datos registrales. T 1187 , F 117, S 8, H BI 2235,A , I/ 40 .(22.09.16).
29 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: DAVID BENJAMIN. Datos registrales. T 1187 , F 117, S 8, H BI 2235,A , I/ 39 .(12.09.16).
11 de Enero de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ZORTZI LEHENGUSUAK SOCIEDAD LIMITADA. IBERTIF FERROCARRILESSOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 1187 , F 104, S 8, H BI 2235,A , I/ 38 .(30.12.15).
04 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BERGE ARZADUN MARTA. Secretario: BERGE ARZADUN MARTA. Consejero: ARZADUNLARRUCEA MARIA. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ARZADUN TRUJILLO ROSALIA. Presidente:ARZADUN TRUJILLO ROSALIA. Nombramientos. Consejero: BILBAO ARZADUN JULEN;BERGE ARZADUN MARTA;ARZADUNLARRUCEA MARIA. Presidente: BILBAO ARZADUN JULEN. Secretario: BERGE ARZADUN MARTA. Datos registrales. T 1187 , F103, S 8, H BI 2235,A , I/ 36 .(23.07.14).
Nombramientos. Apoderado: TSORBA FRANCK DIMITRI. Datos registrales. T 1187 , F 104, S 8, H BI 2235,A , I/ 37 .(23.07.14).
09 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: ARZADUN LARRUCEA JULEN;BERGE ARZADUN MARTA. Nombramientos. Apoderado: ARZADUNLARRUCEA JULEN;BERGE ARZADUN MARTA. Datos registrales. T 1187 , F 102, S 8, H BI 2235,A , I/ 35 .(27.06.13).
12 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: AGUILEDA ARCO ATLANTICO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1187 , F 102, S 8, H BI 2235,A ,I/ 34 .( 5.02.13).
07 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LARRUCEA LEZAMIZ MARIA PILAR. Nombramientos. Consejero: ARZADUN LARRUCEA MARIA.Datos registrales. T 1187 , F 102, S 8, H BI 2235,A , I/ 33 .(21.10.11).
17 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: ARZADUN TRUJILLO JULIAN. Datos registrales. T 1187 , F 100, S 8, H BI 2235,A , I/ 31 .(27.07.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARZADUN LARRUCEA JULEN;BERGE ARZADUN MARTA. Datos registrales. T 1187 , F 100, S 8, HBI 2235,A , I/ 32 .( 1.08.11).
19 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BERGE ARZADUN ELENA. Secretario: BERGE ARZADUN ELENA. Nombramientos. Consejero:BERGE ARZADUN MARTA. Secretario: BERGE ARZADUN MARTA. Datos registrales. T 1187 , F 100, S 8, H BI 2235,A , I/ 29 .(7.07.10).
Nombramientos. Auditor: AGUILEDA ARCO ATLANTICO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1187 , F 100, S 8, H BI2235,A , I/ 30 .( 8.07.10).
21 de Mayo de 2009Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL BILDOSOA AUZUNEA - PABELLON K-2 (ARTEA). Datos registrales. T 1187 , F99, S 8, H BI 2235,A , I/ 28 .( 5.05.09).
07 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: URIBARRI ECHEBARRIA GOTZON. Datos registrales. T 1187 , F 98, S 8, H BI 2235,A , I/ 27.(22.04.09).