Actos BORME de Arco 2000 Sl
01 de Junio de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.682.628,82 Euros. Resultante Suscrito: 10.317.371,18 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.717.371,18 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:6.717.371,18 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Otros conceptos: Se deja sin efecto la escritura autorizada por lanotario de Madrid do帽a Mar铆a Dolores Torres Vila el d铆a 17 de marzo de 2023, n煤mero de protocolo 285 que fue presentada en esteRegistro Mercantil con el n煤mero 49786 y calificada defectuosa. Datos registrales. T 14472 , F 214, S 8, H M 40928, I/A 39(25.05.23).
17 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ- AGUAYO SANCHEZ-CABALLERO JULIO FERNANDO. Nombramientos. Adm.Solid.: FERNANDEZ AGUAYO ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 14472 , F 214, S 8, H M 40928, I/A 38 (10.06.22).
27 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MINGUEZ NAVARRO JOAQUIN ANGEL. Nombramientos. Adm. Solid.: MINGUEZ CANOJOAQUIN ANGEL. Datos registrales. T 14472 , F 213, S 8, H M 40928, I/A 37 (19.12.18).
29 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ AGUAYO ALONSO CARLOS;MINGUEZ CANO JOAQUIN ANGEL. Datos registrales. T14472 , F 213, S 8, H M 40928, I/A 36 (20.09.16).
19 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MINGUEZ NAVARRO JOAQUIN ANGEL. Presidente: MINGUEZ NAVARRO JOAQUIN ANGEL.Cons.Del.Sol: MINGUEZ NAVARRO JOAQUIN ANGEL. Consejero: CANO LOPEZ MARIA DEL CARMEN;FERNANDEZ SANCHEZ-CABALLERO JULIO FERNANDO. Secretario: FERNANDEZ SANCHEZ-CABALLERO JULIO FERNANDO. Cons.Del.Sol:FERNANDEZ SANCHEZ-CABALLERO JULIO FERNANDO. Consejero: ALONSO RAMOS MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Adm. Solid.: MINGUEZ NAVARRO JOAQUIN ANGEL;FERNANDEZ AGUAYO SANCHEZ CABALLERO JULIO FERNANDO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T14472 , F 213, S 8, H M 40928, I/A 35 (11.11.15).
17 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 14472 , F 212, S 8, H M 40928, I/A 34 ( 9.01.14).
05 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 14472 , F 212, S 8, H M 40928, I/A 33 (25.02.13).
27 de Enero de 2012Reelecciones. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 14472 , F 212, S 8, H M 40928, I/A 32 (17.01.12).
02 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGASECONOMISTAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 14472 , F 212, S 8, H M 40928, I/A 31 (20.01.11).
27 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTASAUDITORES SL. Datos registrales. T 14472 , F 211, S 8, H M 40928, I/A 30 (13.01.10).
26 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES SL. Reelecciones. Aud.C.Con.: LATORRE Y VEGASECONOMISTAS AUDITORES SL. Datos registrales. T 14472 , F 211, S 8, H M 40928, I/A 29 (13.02.09).