Actos BORME de Area De Desarrollo Del Poligono Industrial San Antonio Sl
09 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Presidente: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Consejero: VARGASBARRENA ANTONIO LUIS. Vicepresid.: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Consejero: RUIZ GOMEZ MARIA EUGENIA;LEONSEDANO JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: BLASCO JUAREZ ANA BELEN. Presidente: BLASCO JUAREZ ANABELEN. Consejero: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Vicepresid.: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Consejero: RUIZ GOMEZMARIA EUGENIA;LEON SEDANO JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. Datosregistrales. T 2372 , F 96, S 8, H CO 11514, I/A 20 (29.09.23).
09 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Presidente: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Consejero: VARGASBARRENA ANTONIO LUIS. Vicepresid.: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Consejero: RUBIO HERRADOR AURORA;LOPEZ RIOFELIPE. Nombramientos. Consejero: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Presidente: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Consejero:VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Vicepresid.: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Consejero: RUIZ GOMEZ MARIAEUGENIA;LEON SEDANO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2372 , F 95, S 8, H CO 11514, I/A 19 (27.09.19).
22 de Agosto de 2018Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n social.-. Datos registrales. T 2372 , F 95, S 8, H CO 11514, I/A 18 (13.08.18).
21 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO HERRADOR AURORA. Presidente: RUBIO HERRADOR AURORA. Consejero: DIAZ LUNARJUAN JOSE. Vicepresid.: DIAZ LUNAR JUAN JOSE. Consejero: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Nombramientos. Consejero:PORRAS FERNANDEZ JOSE. Presidente: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Consejero: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS.Vicepresid.: VARGAS BARRENA ANTONIO LUIS. Consejero: RUBIO HERRADOR AURORA;LOPEZ RIO FELIPE. Datos registrales.T 2372 , F 94, S 8, H CO 11514, I/A 17 (15.07.15).
29 de Abril de 2014Modificaciones estatutarias. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. Cambio de objeto social. a.- La actividad de urbanizaci贸n,explotaci贸n y desarrollo de铆 Pol铆gono Industrial San Antonio de Belmez, tanto del existente a la firma de los presentes Estatutos comoel resto de Pol铆gonos industriales, de propiedad municipal, que pudieran constituirse, y que se ubiquen dentro del t茅rmino municipa.Datos registrales. T 2372 , F 94, S 8, H CO 11514, I/A 16 (22.04.14).
13 de Noviembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 359.626,12 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros. Otros conceptos: Refundici贸ntotal de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1332 , F 13, S 8, H CO 11514, I/A 15 ( 6.11.13).
27 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NAVARRETE MANCHADO ROGELIO. Nombramientos. SecreNoConsj: NAVAS CHAVELIDAZA AGUSTIN. Datos registrales. T 1332 , F 13, S 8, H CO 11514, I/A 14 (20.09.12).
08 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MOGOLLON BRAVO JUAN MANUEL. Presidente: MOGOLLON BRAVO JUAN MANUEL. Consejero:DIAZ LUNAR JUAN JOSE;PORRAS FERNANDEZ JOSE;PEREZ DURAN ANGEL MARIA. Nombramientos. Consejero: RUBIOHERRADOR AURORA. Presidente: RUBIO HERRADOR AURORA. Consejero: DIAZ LUNAR JUAN JOSE. Vicepresid.: DIAZ LUNARJUAN JOSE. Consejero: PORRAS FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 1332 , F 12, S 8, H CO 11514, I/A 13 (29.08.11).
26 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ FERNANDEZ LAURA MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: NAVARRETEMANCHADO ROGELIO. Datos registrales. T 1332 , F 12, S 8, H CO 11514, I/A 12 (15.07.10).
23 de Marzo de 2010Otros conceptos: Refundici贸n total de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1332 , F 8, S 8, H CO 11514, I/A 11 (11.03.10).
28 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: MORENO DIAZ MIGUEL ANGEL. Consejero: MORENO DIAZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Secretario: SANCHEZ FERNANDEZ LAURA MARIA. Datos registrales. T 1332 , F 8, S 8, H CO 11514, I/A 10 (19.05.09).