Buscador CIF Logo

Actos BORME Arenal Perfumerias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arenal Perfumerias Sl

Actos BORME Arenal Perfumerias Sl - B27147297

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Arenal Perfumerias Sl con CIF B27147297

馃敊 Perfil de Arenal Perfumerias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lugo

Actos BORME de Arenal Perfumerias Sl

21 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 566 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 47(10.11.23).

20 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO. Nombramientos. Consejero: DOS SANTOSFERNANDES DE OLIVEIRA MARGARIDA RITA. Datos registrales. T 566 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 45 (10.10.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TEIXEIRA SOARES DE ALMEIDA RUI MANUEL. Nombramientos. Consejero: PEIXOTO VANZELLER FERNANDO. Datos registrales. T 566 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 46 (10.10.23).

09 de Octubre de 2023
Otros conceptos: SE INCLUYE EL NUMERO DE NIE vigente de D. Paulo Jorge Francisco Andr茅 como apoderado del Grupo B,INSCRIPCION 36陋 de la sociedad de esta Hoja. Datos registrales. T 566 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 43 (29.09.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: ECHEVARRIA CARRILLO JUNCAL. Datos registrales. T 566 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 44 (29.09.23).

24 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 532 , F 224, S 8, H LU 729, I/A 42(17.11.22).

26 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 532 , F 223, S 8, H LU 729, I/A 41 (19.09.22).

27 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 532 , F 223, S 8, H LU 729, I/A 40(14.10.21).

03 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 532 , F 223, S 8, H LU 729, I/A 39(25.11.20).

08 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINS VALADA MARIA INES. Nombramientos. Consejero: VIEIRA AGUAS MIGUEL PASCOA.Datos registrales. T 532 , F 222, S 8, H LU 729, I/A 38 (21.08.20).

24 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINS VALADA MARIA INES. Nombramientos. Apo.Manc.: VIEIRA AGUAS MIGUEL PASCOA.Datos registrales. T 532 , F 221, S 8, H LU 729, I/A 37 (17.08.20).

21 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: MORAIS ARAGONEZ PEDRO DANIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO ANDRE PAULOJORGE;MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS. Datos registrales. T 496 , F 144, S 8, H LU 729, I/A 36 (9.07.20).

08 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 496 , F 144, S 8, H LU 729, I/A 35(30.10.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Secretario: AMEIJENDA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Con.Delegado: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Datosregistrales. T 496 , F 140, S 8, H LU 729, I/A 33 (14.03.19).

26 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL;LAVILLA RUBIRACARLOS;ALONSO DURAN ALFONSO. Secretario: REGOJO BALBOA PEDRO. Vicesecret.: TATO SUAREZ CARMEN. Presidente:VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Nombramientos. Consejero: MESQUITA-SOARES MOUTINHO LUIS MIGUEL. Presidente: MESQUITA-SOARES MOUTINHO LUIS MIGUEL. Consejero: TEIXEIRA SOARES DE ALMEIDA RUI MANUEL;MARTINS VALADA MARIAINES;DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO. Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de estatutos.. Datosregistrales. T 496 , F 140, S 8, H LU 729, I/A 33 (14.03.19).

Revocaciones. Apoderado: WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO;WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO;WIRZ RODRIGUEZNICOLAS ALBERTO;VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Apo.Sol.: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS. Apoderado:WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Nombramientos. Apo.Manc.: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;MORAIS ARAGONEZPEDRO DANIEL. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ REIJA RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;MORAIS ARAGONEZ PEDRODANIEL;CARVALHO DE SOUSA ANDRE;SEQUEIRA DE ALMEIDA DOMINGOS MIGUEL;RODRIGUES MARQUES JONIMARLON;VILAS BOAS GARRIDO EDUARDO MANUEL;ORTEGA CARVALHO JORGE;VAZQUEZ REIJA RAFAEL;VAZQUEZMARZAN CARLOS;WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO;MESQUITA-SOARES MOUTINHO LUIS MIGUEL;TEIXEIRA SOARESDE ALMEIDA RUI MANUEL;MARTINS VALADA MARIA INES;DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO;MARZANVAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 496 , F 143, S 8, H LU 729, I/A 34 (14.03.19).

05 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Datos registrales. T 496 , F 139, S 8, H LU 729, I/A 31(24.08.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: PRIETO PAVON ANA MARIA;FOUCES LAGO MARCOS;PI脩EIRO FERNANDEZ MARIA-LUZ;LOPEZ GILMARIA VICTORIA;SALAS DE LA PUENTE ANDREA;CODESIDO NU脩EZ HECTOR TOMAS;LOPEZ TORRES JESUS;PORTELAJUSTO MARGARITA;GARCIA SOUTO CRISTINA;DE CASTRO CORRAL AIDA;REY GONZALEZ FAUSTO;ARCEO TOURISCRISTINA;ALLER ARGUERO CLAUDIA;ECHEVARRIA CARRILLO JUNCAL;CANTERO GONZALEZ MARTA;VIGIL GARCIAISABEL;LOPEZ BERDEAL MARIA ANGELES;ZABALLOS GARCIA PALOMA;REY FUENTES SERGIO;MANERO BLANCOJESSICA;PRIETO BUENAVIA PAMELA. Datos registrales. T 496 , F 140, S 8, H LU 729, I/A 32 (24.08.18).

29 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ CARBAJALES ANTONIO. Datos registrales. T 496 , F 139, S 8, H LU 729, I/A 30(20.06.18).

24 de Abril de 2017
Modificaciones estatutarias. Remuneraci贸n de los administradores. El cargo de administrador, en su condici贸n de tal es retribuido.La retribuci贸n consiste en una cantidad dinerario anual que determinara la Junta General de Socios para cada ejercicio,correspondiendo asimismo a la Junta la distribuci贸n de dicha cantidad entre. Datos registrales. T 496 , F 139, S 8, H LU 729, I/A 29(10.04.17).

14 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ REIJA RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Datosregistrales. T 488 , F 26, S 8, H LU 729, I/A 27 ( 6.03.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ CASTRO OSCAR;FERNANDEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN;MATICES PEREZ CARLOS;PEREZCASTELAO VANESSA;CARREIRAS CABADO GONZALO;CAMPO SANJURJO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 488 , F 26,S 8, H LU 729, I/A 28 ( 6.03.17).

15 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Secretario: SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Auditor: SANCHEZLOPEZ MANUEL VICTOR. Consejero: CURTO IZQUIERDO ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ REIJA RAFAEL.Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Secretario: REGOJO BALBOA PEDRO. Apoderado: LOPEZ PITA JAVIERVICENTE. Consejero: ALONSO DURAN ALFONSO. Datos registrales. T 488 , F 25, S 8, H LU 729, I/A 26 (30.11.16).

06 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Datos registrales. T 487 , F 17, S 8, H LU 729, I/A 25 (24.05.16).

02 de Junio de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ MARZAN RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS. Datos registrales. T 487 , F 13, S 8, H LU729, I/A 23 (24.05.16).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TOMENIDER SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VAZQUEZ REIJARAFAEL;MARZAN IGLESIAS MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Presidente: VAZQUEZREIJA RAFAEL. Consejero: SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Secretario: SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Consejero:MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;GARCIA VERGARA GORKA;CURTO IZQUIERDO ALBERTO;LAVILLARUBIRA CARLOS. Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 487, F 14, S 8, H LU 729, I/A 24 (24.05.16).

01 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ MARZAN RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS. Datos registrales. T 487 , F 13, S 8, H LU729, I/A 23 (24.05.16).

05 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Datos registrales. T 487 , F 12, S 8, H LU 729, I/A 22(26.04.16).

04 de Mayo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.335,52 Euros. Resultante Suscrito: 19.705,28 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: VAZMAR LUCUS SL. Datos registrales. T 405 , F 72, S 8, H LU 729, I/A 21 (22.04.16).

04 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. 5. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 405 , F 72, S 8, H LU 729, I/A 20 (22.03.16).

27 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apoderado: WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Datos registrales. T 405 , F 71, S 8, H LU 729, I/A 19(20.08.14).

13 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Aud.Supl.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Datos registrales. T 405 , F71, S 8, H LU 729, I/A 18 ( 3.12.13).

22 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Datos registrales. T 405 , F 71, S 8, H LU 729, I/A 17 (9.10.12).

28 de Septiembre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ARENAL PROFAR SL. Datos registrales. T 405 , F 70, S 8, H LU 729, I/A 16(13.09.11).

26 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: ALBERTO LEIRO CASTRO. Aud.Supl.: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Nombramientos.Auditor: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Aud.Supl.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Datos registrales. T 405 , F 70, S 8, H LU729, I/A 15 (12.01.11).

22 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: ALBERTO LEIRO CASTRO. Aud.Supl.: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 405 , F70, S 8, H LU 729, I/A 14 ( 9.01.10).

21 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: ALBERTO LEIRO CASTRO. Aud.Supl.: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 163 , F90, S 8, H LU 729, I/A 13 ( 8.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n