Actos BORME de Aridos De Villacastin Sa
04 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: COMPRAS Y LOGISTICA BURGALESA SL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ GONZALEZJUAN MANUEL. Otros conceptos: Ratificados los nombramientos de consejeros por cooptaci贸n de don Jos茅 Chamizo Carmona ydon Jos茅 Javier Cameo Bel, realizados por el consejo de fecha 24 de enero de 2018.- Cesado como representante don RamiroSantiuste Garcia.- Datos registrales. T 37530 , F 221, S 8, H M 354401, I/A 5 (25.02.19).
Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37530 , F 222, S 8, H M 354401, I/A 6 (25.02.19).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP. Datos registrales. T 37530 , F 221, S 8, H M 354401, I/A 4 (27.04.18).
19 de Abril de 2018Cambio de domicilio social. C/ IGANACIO ELLACURIA 3 (MADRID). Datos registrales. T 37530 , F 221, S 8, H M 354401, I/A 3(11.04.18).
14 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL. Cons.Del.Sol: GESTORA DE INVERSIONESENEREN XXI SL. Presidente: GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL. Consejero: GRUPO ASUARI INVERSOR SL.Cons.Del.Sol: GRUPO ASUARI INVERSOR SL. Vicepresid.: GRUPO ASUARI INVERSOR SL. SecreNoConsj: RUIZ FERREIROPABLO. Nombramientos. Consejero: CAMEO BEL JOSE JAVIER;CHAMIZO CARMONA JOSE. Presidente: CAMEO BEL JOSEJAVIER. Vicepresid.: CHAMIZO CARMONA JOSE. Secretario: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN RAMON JAIME. Datos registrales.T 739, L 530, F 142, S 8, H BU 10781, I/A 23 ( 7.02.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO ALVAREZ MANUEL RAFAEL. Apo.Manc.: SANTIUSTE GARCIA RAMIRO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMEO BEL JOSE JAVIER;CHAMIZO CARMONA JOSE;SANCHEZ GONZALEZ JUAN MANUEL.Datos registrales. T 739, L 530, F 142, S 8, H BU 10781, I/A 24 ( 7.02.18).
02 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: VEGA GOICOLEA LUIS. Apo.Man.Soli: ALONSO ALVAREZ MANUEL RAFAEL. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ALONSO ALVAREZ MANUEL RAFAEL. Apo.Manc.: SANTIUSTE GARCIA RAMIRO. Datos registrales. T 674, L 465,F 99, S 8, H BU 10781, I/A 22 (26.01.16).
13 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Datos registrales. T 674, L 465, F 97, S 8, H BU 10781, I/A 20 (5.11.15).
22 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: GRUPO ASUARI INVERSOR SL. Vicepresid.: GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL.Nombramientos. Presidente: GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL. Vicepresid.: GRUPO ASUARI INVERSOR SL. Datosregistrales. T 674, L 465, F 97, S 8, H BU 10781, I/A 19 (14.08.14).
17 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO. Apo.Manc.: VEGA GOICOLEA LUIS.Nombramientos. Apo.Manc.: VEGA GOICOLEA LUIS. Apo.Man.Soli: ALONSO ALVAREZ MANUEL RAFAEL. Datos registrales. T631, L 422, F 59, S 8, H BU 10781, I/A 17 (11.02.14).
24 de Diciembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.265.049,80 Euros. Resultante Suscrito: 10.318.560,20 Euros. Datos registrales. T 631,L 422, F 58, S 8, H BU 10781, I/A 16 (17.12.13).
29 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO;ANTOLIN TOLEDANO JOSE. Presidente: ANTOLIN TOLEDANOJOSE. Consejero: VEGA GOICOLEA LUIS. Vicepresid.: ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Cons.Del.Sol: ANTOLIN TOLEDANOJOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Nombramientos. Consejero: GRUPO ASUARI INVERSOR SL;GESTORA DE INVERSIONESENEREN XXI SL;COMPRAS Y LOGISTICA BURGALESA SL. Presidente: GRUPO ASUARI INVERSOR SL. Vicepresid.: GESTORADE INVERSIONES ENEREN XXI SL. Datos registrales. T 631, L 422, F 57, S 8, H BU 10781, I/A 14 (22.08.13).
Nombramientos. Cons.Del.Sol: GRUPO ASUARI INVERSOR SL;GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL. Datosregistrales. T 631, L 422, F 58, S 8, H BU 10781, I/A 15 (22.08.13).
22 de Mayo de 2013Fe de erratas: Se rectifica la inscripici贸n 13& en cuanto a las facultades conferidas concar谩cter mancomunado siendo las contenidasbajo los n煤meros 15, 16 y 17. Datos registrales. T 631, L 422, F 56, S 8, H BU 10781, I/A 13 b (14.05.13).
14 de Marzo de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;SANTAMARIA MARTIN DAVID.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO. Apo.Manc.: VEGA GOICOLEA LUIS.Datos registrales. T 631, L 422, F 56, S 8, H BU 10781, I/A 13 ( 7.03.13).
08 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;CALDERON FRANCISCO CARMEN.Nombramientos. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;SANTAMARIA MARTIN DAVID. Datosregistrales. T 596, L 387, F 207, S 8, H BU 10781, I/A 12 (28.02.11).
30 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: ANTOLIN TOLEDANO JOSE;SAN AGAPITO RAMOS FLORENCIO;ARRANZ ACINASJESUS;RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Apo.Man.Soli: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO. Apo.Manc.: VEGAGOICOLEA LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;CALDERON FRANCISCOCARMEN. Datos registrales. T 596, L 387, F 207, S 8, H BU 10781, I/A 11 (22.12.10).
24 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.500.000,00 Euros. Desembolsado: 7.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.583.610,00 Euros.Resultante Desembolsado: 12.583.610,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 205, S 8, H BU 10781, I/A 10 (13.05.10).
04 de Marzo de 2010Nombramientos. Cons.Del.Sol: ANTOLIN TOLEDANO JOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Datos registrales. T 596, L 387, F205, S 8, H BU 10781, I/A 9 (23.02.10).
08 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRANZ ACINAS JESUS;SAN AGAPITO RAMOS FLORENCIO. Secretario: VEGA GOICOLEA LUIS.Nombramientos. Consejero: ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. SecreNoConsj: RUIZ FERREIRO PABLO. Consejero: VEGAGOICOLEA LUIS. Vicepresid.: ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE;ANTOLINTOLEDANO JOSE. Presidente: ANTOLIN TOLEDANO JOSE. Datos registrales. T 596, L 387, F 204, S 8, H BU 10781, I/A 8(28.01.10).