Actos BORME de Ariel Park Sl
24 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ RIPOLL ANA MARIA;FUSTER LLORENS PEDRO. Datos registrales. T 3719 , F 123, S 8, H A19275, I/A 27 (12.03.21).
17 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: CABALLE TURA NATALIA. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA. Apo.Manc.: LLORCA RAMIREZ JAIME.Apo.Sol.: LLORCA RAMIREZ JAIME. Apo.Manc.: PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Apo.Sol.: PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Datosregistrales. T 3719 , F 123, S 8, H A 19275, I/A 26 (10.02.21).
10 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Apo.Manc.: CABALLETURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3719 , F 123, S 8, H A 19275, I/A 25(30.08.18).
05 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;LLORCA RAMIREZ JAIME;PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Apo.Manc.:CABALLE TURA NATALIA;LLORCA RAMIREZ JAIME;PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Datos registrales. T 3719 , F 122, S 8, H A19275, I/A 24 (28.08.18).
17 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CABALLE HORTA JORGE. Datos registrales. T 3719 , F 122, S 8, H A 19275, I/A 23 ( 8.05.18).
26 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: ESPACIO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3719 , F 121, S 8, H A 19275, I/A 22 (18.02.16).
15 de Septiembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 699.996,96 Euros. Resultante Suscrito: 1.305.214,56 Euros. Datos registrales. T 3719 , F 121, S 8,H A 19275, I/A 21 ( 9.09.15).
03 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: PENIDO MEDINA MARIA GEMA. Datos registrales. T 3719 , F 121, S 8, H A 19275, I/A 20 (25.11.13).
25 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABALLE HORTA JORGE;CABALLE TURA JOSE MARIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCARAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3719 , F 121, S 8, H A 19275, I/A 19 (18.10.13).
23 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Apo.Manc.: CABALLETURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3719 , F 119, S 8, H A 19275, I/A 18(16.10.13).
18 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: CABALLE HORTA JORGE. Datos registrales. T 2887 , F 53, S 8, H A 19275, I/A 17 (11.10.13).
21 de Agosto de 2013Otros conceptos: Modificados la totalidad de los Estatutos. Datos registrales. T 2887 , F 51, S 8, H A 19275, I/A 16 (13.08.13).
28 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: PENIDO MEDINA MARIA GEMA. Datos registrales. T 2887 , F 51, S 8, H A 19275, I/A 15 (18.01.10).