Buscador CIF Logo

Actos BORME Arioso Spain 2 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arioso Spain 2 Sl

Actos BORME Arioso Spain 2 Sl - B86857646

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Arioso Spain 2 Sl con CIF B86857646

馃敊 Perfil de Arioso Spain 2 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Arioso Spain 2 Sl

12 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: VILA PUMARES MARIA CRUZ;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;NAVAS GUTIERREZ ARMANDOIGNACIO;CABRERA HERNANDEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 32934 , F 185, S 8, H M 570622, I/A 17 ( 3.11.21).

26 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: YBERN SALCEDO JULIO. Otros conceptos: VARIACION EN LOS ADMINISTRADORESMANCOMUNADOS QUE COMPONEN LOS GRUPOS I Y II. Datos registrales. T 32934 , F 182, S 8, H M 570622, I/A 15 (19.01.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVAS GUTIERREZ ARMANDO IGNACIO;CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;YBERNSALCEDO JULIO;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;RODRIGUEZ DE GUZMAN VALLES MANUEL;SORIANO RAGA JOSEJORDI;DE SIMON FERRERAS EDUARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;NAVASGUTIERREZ ARMANDO IGNACIO;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;RODRIGUEZ DE GUZMAN VALLES MANUEL;SORIANO RAGAJOSE JORDI;DE SIMON FERRERAS EDUARDO. Datos registrales. T 32934 , F 182, S 8, H M 570622, I/A 16 (19.01.21).

Otros conceptos: ACTA DE IDENTIFACION DEL TITULAR REAL. Datos registrales. T 31713 , F 208, S 8, H M 570622, I/A 1M(19.01.21).

11 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: NAVASGUTIERREZ ARMANDO IGNACIO. Datos registrales. T 32934 , F 182, S 8, H M 570622, I/A 14 ( 3.05.18).

27 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 32934 , F 182, S 8, H M 570622, I/A 13(20.03.18).

09 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;YBERN SALCEDO JULIO;MORALES-ARCE SERRANOALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: BRENINKMEIJER PATRICK MARTIN;YBERN SALCEDO JULIO;CASANOVALAFUENTE JOSE ISRAEL;MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 8潞 Y 11潞 DE LA SOCIEDAD. . Datos registrales. T 32934 , F 181, S 8, H M 570622, I/A 11 ( 2.06.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE OYA JIMENEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 32934 , F 181, S 8, H M 570622, I/A 12 (2.06.17).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVAS GUTIERREZ ARMANDO IGNACIO;CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;YBERNSALCEDO JULIO;MORALES-ARCE SERRANO ALVARO;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;RODRIGUEZ DE GUZMAN VALLESMANUEL;SORIANO RAGA JOSE JORDI;DE OYA JIMENEZ JOSE CARLOS;DE SIMON FERRERAS EDUARDO. Datos registrales.T 32934 , F 178, S 8, H M 570622, I/A 10 (28.12.16).

04 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO;CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;RODRIGUEZ DE GUZMAN VALLESMANUEL;DE OYA JIMENEZ JOSE CARLOS;NAVAS GUTIERREZ ARMANDO IGNACIO;MORALES-ARCE SERRANOALVARO;MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Apo.Man.Soli: DE SIMON FERRERAS EDUARDO;SORIANO RAGA JOSEJORDI;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO. Datos registrales. T 32934 , F 178, S 8, H M 570622, I/A 9 (22.12.16).

16 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;SORIANO RAGA JOSE JORDI. Nombramientos. Apo.Man.Soli:SORIANO RAGA JOSE JORDI;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO. Datos registrales. T 32934 , F 176, S 8, H M 570622, I/A 8 (6.11.15).

15 de Enero de 2015
Revocaciones. Apoderado: EGGENKAMP MARCEL GERARDUS;MARTIN VICENTE MAZARIEGOS MARIA DE LA ASUNCION.Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE SIMON FERRERAS EDUARDO. Datos registrales. T 31713 , F 215, S 8, H M 570622, I/A 7 (8.01.15).

14 de Enero de 2015
Modificaciones estatutarias. SE SUBSANA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION EN CUANTO A LA REDACCION DEL ARTICULO11 DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 31713 , F 215, S 8, H M 570622, I/A 6 ( 2.01.15).

01 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 31713 , F 215, S 8, H M 570622, I/A 5(23.06.14).

Revocaciones. Apoderado: HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Datos registrales. T 31713 , F 213, S 8, H M 570622, I/A 4(23.06.14).

11 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: EGGENKAMP MARCEL GERARDUS;HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Nombramientos.Adm. Mancom.: MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 31713 , F 212, S 8, H M 570622, I/A 3 (28.02.14).

17 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER;YBERN SALCEDO JULIO;EGGENKAMP MARCELGERARDUS;CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;RODRIGUEZ DE GUZMAN VALLES MANUEL;MARTIN VICENTEMAZARIEGOS MARIA DE LA ASUNCION;DE OYA JIMENEZ JOSE CARLOS;GALDEANO VILLEGAS IGNACIO;SORIANO RAGAJOSE JORDI;NAVAS GUTIERREZ ARMANDO IGNACIO;MORALES ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 31713 , F 210,S 8, H M 570622, I/A 2 (10.01.14).

18 de Diciembre de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.11.13. Objeto social: 1 .- La adquisici贸n, arrendamiento, cesi贸n a terceros por cualquiert铆tulo, enajenaci贸n y administraci贸n y explotaci贸n en general de toda clase de bienes inmuebles. CNAE 6820. Domicilio: PLAZA DELMARQUES DE SALAMANCA 3-4 2 (MADRID). Capital: 10.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ARIOSOAG. Nombramientos. Adm. Mancom.: CASANOVA LAFUENTE JOSE ISRAEL;EGGENKAMP MARCEL GERARDUS;YBERNSALCEDO JULIO;HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Datos registrales. T 31713 , F 208, S 8, H M 570622, I/A 1 (10.12.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n