Actos BORME de Armando Alvarez Sa
18 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SANTIAGO GONZALEZ JESUS-ANGEL;RONCAL BERRUEZO JOSE MARIA. Datos registrales. T31346 , F 175, S 8, H M 29301, I/A 111 (11.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ ALDOMA ANNA-ROSA;ALBARRAN ALVEAR JUAN. Datos registrales. T 31346 , F 176,S 8, H M 29301, I/A 112 (11.12.23).
26 de Octubre de 2023Reelecciones. Aud.C.Con.: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31346 , F 175, S 8, H M 29301, I/A 110(19.10.23).
01 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31346 , F 175, S 8, H M 29301, I/A 109(25.08.23).
31 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Fe de erratas: Se omitió por error en la inscripción 94ª lapublicación de la reelección del auditor ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M29301, I/A 94 (14.08.20).
25 de Agosto de 2023Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 40º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 31346 ,F 175, S 8, H M 29301, I/A 108 (18.08.23).
24 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: SAIZ RUIZ FRANCISCO JAVIER;GARRIDO HALCON TELESFORO;GARRIDO HALCONTELESFORO;GUTIERREZ NUÑEZ ELOY. Apo.Man.Soli: ACEREDA FERNANDEZ MARIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ VIÑAS JESUS.Datos registrales. T 31346 , F 174, S 8, H M 29301, I/A 107 (17.05.23).
27 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON.Presidente: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE-RAMON. Nombramientos. Consejero: BUSCARDEL SL;ALVAREZ ALDOMA ANNA-ROSA. Presidente: BUSCARDEL SL. Cons.Del.Sol: BUSCARDEL SL. Vicepresid.: ALVAREZ ALDOMA ANNA-ROSA. Datosregistrales. T 31346 , F 174, S 8, H M 29301, I/A 106 (20.02.23).
31 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUA ARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA ELENA;ALVAREZ RIBALAYGUAMARIA. Vicepr.1: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Consejero: PRIETO ALVAREZJORGE. Nombramientos. Consejero: ARALRIBA SL;PRIALJO SL;ELISARMA SL;FONTIMOSA DE INVERSIONES SL. Vicepresid.:FONTIMOSA DE INVERSIONES SL. Con.Delegado: FONTIMOSA DE INVERSIONES SL. Representan: ALVAREZ RIBALAYGUAARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA ELENA;ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA;PRIETO ALVAREZ JORGE. Modificacionesestatutarias. Modificación del artículo 40º de los estatutos sociales Modificación del artículo 40º de los estatutos sociales. Datosregistrales. T 31346 , F 173, S 8, H M 29301, I/A 105 (24.01.23).
06 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. CREACION DE UN NUEVO ARTICULO 12º BIS) EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, A FIN DE
29 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-PAREST PEREZ MARIA. Datos registrales. T 31346 , F 171, S 8, H M 29301, I/A 102(22.08.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 31346 , F 171, S 8, H M 29301, I/A 103(22.08.22).
22 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA NIETO JESUS;GARCIA NIETO JESUS. Datos registrales. T 31346 , F 170, S 8, H M 29301,I/A 101 (15.07.22).
24 de Noviembre de 2021Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: DALTAR SA. Datos registrales. T 31346 , F 168, S 8, H M 29301, I/A 100(17.11.21).
16 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: SALCINES CORREA ALFONSO. Secretario: SALCINES CORREA ALFONSO. Vicepr.2: GOMEZAROZAMENA GONZALO. Consejero: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Cons.Del.Sol:ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUA ARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUAELENA;ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Presidente: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Vicepr.1: ALVAREZ RIBALAYGUAMARIA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Consejero: PRIETO ALVAREZ JORGE. Cons.Del.Sol: GOMEZ AROZAMENAGONZALO. Datos registrales. T 31346 , F 167, S 8, H M 29301, I/A 99 ( 9.07.21).
04 de Junio de 2021Otros conceptos: RECTIFICADA LA ESCRITURA QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 97ª. Datos registrales. T 31346 , F 167, S 8, HM 29301, I/A 98 (28.05.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Consejero: PRIETO ALVAREZ JORGE. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 40º de losestatutos sociales. Datos registrales. T 31346 , F 166, S 8, H M 29301, I/A 97 (10.02.21).
05 de Febrero de 2021Nombramientos. Cons.Del.Sol: GOMEZ AROZAMENA GONZALO. Datos registrales. T 31346 , F 165, S 8, H M 29301, I/A 96(29.01.21).
05 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: PRIETO ALVAREZ JORGE. Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 95 (26.12.20).
21 de Agosto de 2020Reelecciones. Aud.C.Con.: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 94(14.08.20).
17 de Agosto de 2020Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 40º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCIONDE LOS ADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 93 (10.08.20).
14 de Agosto de 2020Fe de erratas: Se publicó por error la inscripción 92ª de fecha 13/04/2020, siendo la correcta el 07/08/2020. Datos registrales. T31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 92 ( 7.08.20).
20 de Abril de 2020Otros conceptos: SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERO DE D.N.I. CORRECTO DEL APODERADO DON GONZALO GOMEZAROZAMENA ES EL: 13.908.860-R. Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 92 ( 6.04.20).
07 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ROMERO HERRERA JOSE LUIS;SALCINES CORREA ALFONSO.Datos registrales. T 31346 , F 164, S 8, H M 29301, I/A 91 (31.03.20).
06 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUA ANA MARIA. Datos registrales. T 31346 , F 163, S 8, H M 29301, I/A 90(30.03.20).
20 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: BERODIA FERNANDEZ ANGEL FRANCISCO;BERODIA FERNANDEZ ANGEL FRANCISCO. Datosregistrales. T 31346 , F 163, S 8, H M 29301, I/A 89 (13.03.20).
07 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORUÑA ABASCAL LUIS. Datos registrales. T 31346 , F 162, S 8, H M 29301, I/A 88 (28.02.19).
30 de Octubre de 2017Reducción de capital. Importe reducción: 7.350,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.400.650,00 Euros. Datos registrales. T 31346 , F162, S 8, H M 29301, I/A 87 (20.10.17).
11 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBALAYGUA MUÑIZ ANA MARIA. Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 1 , 2, 8 , 11 , 12 , 13º, 14 , 15 , 18 , 20º, 21 , 24º, 25º, 31º, 35º, 38º, 39º, 41 , 43 , 44 , 45 , 51 y 54 de los Estatutos sociales.. Otrosconceptos: REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 31346 , F 157, S 8, H M 29301, I/A 86 ( 3.10.17).
02 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 31346 , F 157, S 8, H M 29301, I/A 85 (17.07.17).
31 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: SANTIAGO GONZALEZ JESUS-ANGEL. Datos registrales. T 31346 , F 156, S 8, H M 29301, I/A 84(20.01.17).
27 de Julio de 2016Reelecciones. Consejero: SALCINES CORREA ALFONSO. Secretario: SALCINES CORREA ALFONSO. Vicepr.2: GOMEZAROZAMENA GONZALO. Consejero: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Cons.Del.Sol:ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Consejero: RIBALAYGUA MUÑIZ ANA MARIA;ALVAREZ RIBALAYGUAARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA ANA MARIA;ALVAREZ RIBALAYGUA ELENA;ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Presidente:ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Vicepr.1: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA.Datos registrales. T 31346 , F 156, S 8, H M 29301, I/A 83 (18.07.16).
17 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Datos registrales. T 31346 , F 156, S 8, H M 29301, I/A 82 (9.03.16).
29 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 21, 29 Y 40 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de objeto
25 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ DIAZ JUAN CARLOS;FERNANDEZ VIÑAS JESUS. Datos registrales. T 31346 , F 155, S 8,H M 29301, I/A 80 (16.02.15).
30 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ROMERO HERRERA JOSE LUIS;CANALES MENDIOLEAIGNACIO;RONCAL BERRUEZO JOSE MARIA;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 31346 , F 154, S 8, H M 29301,I/A 79 (22.10.14).
19 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 31346 , F 154, S 8, H M 29301, I/A 78 ( 4.08.14).
11 de Agosto de 2014Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 21º de los Estatutos Sociales.. Página web de la sociedad. Creación de lapágina web corporativa: www.armandoalvarez.com. Datos registrales. T 31346 , F 154, S 8, H M 29301, I/A 77 ( 1.08.14).
30 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: ROMERO HERRERA JOSE LUIS;CANALES MENDIOLEA IGNACIO;SALCINES CORREA ALFONSO.Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON GONZALO GOMEZ AROZAMENA QUE CAUSO LAINSCRIPCION 57& EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SANTANDER , PRIMERA DE TRASLADO. Datos registrales. T 31346 , F154, S 8, H M 29301, I/A 76 (18.06.14).
26 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ROMERO HERRERA JOSE LUIS;CANALES MENDIOLEAIGNACIO;RONCAL BERRUEZO JOSE MARIA;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 7868 , F 225, S 8, H M 29301,I/A 75 (16.06.14).
22 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ JIMENEZ JOSE VICENTE;SANCHEZ JIMENEZ JOSE VICENTE. Datos registrales. T 7868 ,F 224, S 8, H M 29301, I/A 73 (14.01.14).
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ CAMPO VICENTE;OLIVA SANCHEZ JOSE ANTONIO;SANCHEZ LASTRA MARTINEZERNESTO Otros conceptos: REVOCADO el poder conferido a favor de: Don Angel Alonso Gonzalez, Don Ramon Garayar SanMiguel y Don Arsenio de la Vega Riancho en escritura que causó la inscripcion 18& en el Registro Mercantil de Cantabria, 1& detraslado en este Registro. REVOCADO el poder conferido a favor de: Don Ramon Garayar San Miguel, Don Pedro FernandezMartinez, Don Joaquin Gancedo Olivet y Don Arsenio de la Vega Riancho, en escritura que causó la inscripcion 22& en el RegistroMercantil de Cantabria, 1& de traslado en este Registro. REVOCADO el poder conferido a favor de: Don Jose Angel Robledo Soberonen escritura que causó la inscripcion 42& en el Registro Mercantil de Cantabria, 1& de traslado en este Registro. Datos registrales. T
15 de Enero de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 108.000,00 Euros. Desembolsado: 108.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.408.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 9.408.000,00 Euros. Datos registrales. T 7868 , F 224, S 8, H M 29301, I/A 72 ( 3.01.13).
30 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Vicepr.1: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON.Cons.Del.Sol: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Nombramientos. Presidente: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Vicepr.1:ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA. Datos registrales. T 7868 , F 222, S 8, H M 29301,I/A 71 (18.05.12).
23 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 7868 , F 222, S 8, H M 29301, I/A 70(10.05.12).
16 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ CAMPOS CARLOS. Datos registrales. T 7868 , F 221, S 8, H M 29301, I/A 69 (7.02.12).
28 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA NIETO JESUS. Datos registrales. T 7868 , F 221, S 8, H M 29301, I/A 68 (19.12.11).
26 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 7868 , F 221, S 8, H M 29301, I/A 67 (17.08.11).
12 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Vicepresid.: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON.Secretario: RODRIGUEZ CAMPOS CARLOS. Consejero: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO;RODRIGUEZ CAMPOSCARLOS;ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON;ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA;GOMEZ AROZAMENA GONZALO. Vicepresid.:GOMEZ AROZAMENA GONZALO. Con.Delegado: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUAARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA ANA MARIA;ALVAREZ RIBALAYGUA ELENA;RIBALAYGUA MUÑIZ ANA MARIA.Nombramientos. Consejero: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Presidente: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Consejero:SALCINES CORREA ALFONSO. Secretario: SALCINES CORREA ALFONSO. Vicepr.1: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON.Vicepr.2: GOMEZ AROZAMENA GONZALO. Consejero: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON.Cons.Del.Sol: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE RAMON. Consejero: RIBALAYGUA MUÑIZ ANAMARIA;ALVAREZ RIBALAYGUA ARMANDO;ALVAREZ RIBALAYGUA ANA MARIA;ALVAREZ RIBALAYGUA ELENA;ALVAREZRIBALAYGUA MARIA. Datos registrales. T 7868 , F 220, S 8, H M 29301, I/A 66 (22.07.11).
16 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: CANALES MENDIOLEA IGNACIO;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 7868 , F218, S 8, H M 29301, I/A 64 ( 7.06.11).
Nombramientos. Apoderado: CANALES MENDIOLEA IGNACIO;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 7868 , F219, S 8, H M 29301, I/A 65 ( 7.06.11).
09 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: GOMEZ CASTELL ERNESTO. Datos registrales. T 7868 , F 218, S 8, H M 29301, I/A 63 (25.02.11).
08 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: PARACUELLOS RIVAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 7868 , F 217, S 8, H M 29301, I/A 62(30.08.10).
27 de Abril de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 102.000,00 Euros. Desembolsado: 102.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.300.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 9.300.000,00 Euros. Datos registrales. T 7868 , F 217, S 8, H M 29301, I/A 61 (15.04.10).
11 de Septiembre de 2009Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 40º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCIONDE LOS ADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 7868 , F 216, S 8, H M 29301, I/A 60 ( 1.09.09).