Actos BORME de Armstrong Architectural Products Sl
13 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: AUREN LEGAL SP SLP. Datos registrales. T 33859 , F 32, S 8, H M 507135, I/A 42 ( 3.11.23).
30 de Octubre de 2023Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33859 , F 32, S 8, H M 507135, I/A 41 (23.10.23).
12 de Julio de 2021Cambio de domicilio social. AVDA GENERAL PERON 38 (MADRID). Datos registrales. T 33859 , F 32, S 8, H M 507135, I/A 40 (5.07.21).
26 de Marzo de 2021Fe de erratas: Se publicó por error en la inscripción 37ª el socio único siendo el correcto AURELIUS DEVELOPMENT ELEVENGMBH. Datos registrales. T 33859 , F 31, S 8, H M 507135, I/A 37 (31.08.20).
18 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33859 , F 31, S 8, H M 507135, I/A 38 (11.03.21).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LLORET-LINARES CHRISTOPHE. Nombramientos. Adm. Unico: CLIFFORD TAYLOR GRAHAM.Datos registrales. T 33859 , F 32, S 8, H M 507135, I/A 39 (11.03.21).
07 de Septiembre de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AURELIUS STRATEGIC DEVELOPMENT GMBH. Datosregistrales. T 33859 , F 31, S 8, H M 507135, I/A 37 (31.08.20).
27 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA;LLORET-LINARES CHRISTOPHE. Nombramientos.Adm. Unico: LLORET-LINARES CHRISTOPHE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidariosa Administrador único. Datos registrales. T 33859 , F 31, S 8, H M 507135, I/A 36 (20.07.20).
20 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEMAN CUBILLO CARLOS;WILLIAMS DAVID ANTHONY;CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO;RAMALLEQUIÑONES MARIA;RICHARD HAWRYSCH ENRIQUE;GARCIA-CALZADA VILLAR EUGENIA;SANCHEZ RODRIGUEZBEATRIZ;VARELA CORREA LAURA. Datos registrales. T 33859 , F 31, S 8, H M 507135, I/A 35 (12.05.20).
14 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORET-LINARES CHRISTOPHE;MIDDEL WILLEM ANTONIUS. Presidente: MIDDEL WILLEMANTONIUS. Consejero: WILLIS-JONES WILLIAM MARK. SecreNoConsj: DIAZ HIDALGO JUAN EUGENIO. VsecrNoConsj: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO. Nombramientos. Adm. Solid.: SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA;LLORET-LINARESCHRISTOPHE. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: 15. Organización y de la administración de la sociedad.-. Datosregistrales. T 33859 , F 30, S 8, H M 507135, I/A 34 ( 7.05.20).
16 de Abril de 2020Reelecciones. Consejero: WILLIS-JONES WILLIAM MARK. Datos registrales. T 33859 , F 30, S 8, H M 507135, I/A 33 ( 7.04.20).
12 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 201, S 8, H M 507135, I/A 32 ( 5.02.20).
20 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: THOMSON DANIEL BARRY;SIMPSON GEMMA;BRANNIGAN CATHERINE CLARE;BASILEMIGUEL ANGEL Datos registrales. T 28150 , F 201, S 8, H M 507135, I/A 31 (13.01.20).
06 de Noviembre de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: KNAUF CEILINGS HOLDING GMBH. Datos registrales. T 28150 ,F 201, S 8, H M 507135, I/A 30 (29.10.19).
29 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 201, S 8, H M 507135, I/A 29 (22.01.19).
01 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 200, S 8, H M 507135, I/A 28 (25.01.18).
06 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: TVICA MUAMER. Datos registrales. T 28150 , F 200, S 8, H M 507135, I/A 26 (30.05.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: MUÑOZ BLANCO MARIANA. Nombramientos. Apoderado: CARLOS PENIDO PRATS;BARREIROLAFUENTE CLAUDIA. Datos registrales. T 28150 , F 200, S 8, H M 507135, I/A 27 (30.05.17).
01 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 200, S 8, H M 507135, I/A 25 (22.02.17).
22 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: TEJERA GONZALEZ JULIO. Datos registrales. T 28150 , F 199, S 8, H M 507135, I/A 24 (15.12.16).
07 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: DAVID ALEXANDRE;BADOZ AURELIE;TOMASSONE CRISTINA. Datos registrales. T 28150 , F 199, S8, H M 507135, I/A 23 (23.11.16).
11 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 199, S 8, H M 507135, I/A 22 ( 4.02.16).
30 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE. Presidente: WOLF EDUARD GODEFRIDUSANTONIUS DE. Nombramientos. Consejero: MIDDEL WILLEM ANTONIUS. Presidente: MIDDEL WILLEM ANTONIUS. Datosregistrales. T 28150 , F 185, S 8, H M 507135, I/A 21 (22.12.15).
14 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES MAD SLP. Datos registrales. T 28150 , F 185, S 8, HM 507135, I/A 20 ( 5.10.15).
29 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GRACZYK EVELYNE MARIE JEANNE. Nombramientos. Consejero: LLORET-LINARESCHRISTOPHE. Datos registrales. T 28150 , F 184, S 8, H M 507135, I/A 19 (21.09.15).
28 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: PICARDO SANCHEZ-BRIÑAS MARTA;MUÑOZ BLANCO MARIANA;CENTENERA CRESPOIGNACIO;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA. Datos registrales. T 28150 , F 184, S 8, H M 507135, I/A 18 (21.09.15).
17 de Junio de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 184, S 8, H M 507135, I/A 17 ( 9.06.15).
07 de Mayo de 2015Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 66 (MADRID). Datos registrales. T 28150 , F 183, S 8, H M 507135, I/A15 (27.04.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARROSO BUENDIA MARIA. Datos registrales. T 28150 , F 183, S 8, H M 507135, I/A 16 (27.04.15).
06 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BARROSO BUENDIA MARIA. Nombramientos. Consejero: WILLIS-JONES WILLIAM MARK.Datos registrales. T 28150 , F 183, S 8, H M 507135, I/A 14 (24.04.15).
23 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 183, S 8, H M 507135, I/A 13 (16.05.14).
24 de Enero de 2014Cambio de domicilio social. C/ CALENDULA 95 - MINIPARC II EDIFICIO "M" -PLANTA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T28150 , F 183, S 8, H M 507135, I/A 12 (17.01.14).
01 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ANDINO VILLASANTE JUAN RAMON. Nombramientos. SecreNoConsj: DIAZ HIDALGO JUANEUGENIO. VsecrNoConsj: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 28150 , F 182, S 8, H M 507135, I/A 11(24.09.13).
27 de Junio de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 182, S 8, H M 507135, I/A 10 (19.06.13).
15 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BARROSO BUENDIA MARIA.Datos registrales. T 28150 , F 181, S 8, H M 507135, I/A 8 ( 3.04.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARROSO BUENDIA MARIA. Otros conceptos: Revocados los poderes que le fueron otorgados aD. Antonio Rodríguez Gómez elevados a publico el 13 de Febrero de 1996,ante la Notaria de Barcelona Doña. María Isabel GabarróMiguel, con el número 588 de su protocolo .Revocados los poderes que le fueron otorgados a D. Antonio Rodríguez Gómez elevados apublico el 27 de abril de 2010 elevados a públicos ante el Notario de Barcelona. D. Enrique Hernández Gajate, el 29de abril de 2010con el número de su protocolo 936. Datos registrales. T 28150 , F 181, S 8, H M 507135, I/A 9 ( 3.04.13).
08 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: NUTCHEL ALBERT RUSSELL. Presidente: NUTCHEL ALBERT RUSSELL. Nombramientos.Consejero: WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE. Presidente: WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE. Apoderado:MARTORELL GONZALEZ ISABEL. Datos registrales. T 28150 , F 180, S 8, H M 507135, I/A 6 (26.03.13).
Otros conceptos: RATIFICACION POR LA JUNTA GENERAL DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACION COMO CONSEJERO YPRESIDENTE DE DON EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE WOLF. Datos registrales. T 28150 , F 181, S 8, H M 507135, I/A 7(26.03.13).
02 de Febrero de 2012Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28150 , F 180, S8, H M 507135, I/A 5 (23.01.12).
25 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: EVERINK GUNTER KLAUS. Nombramientos. Consejero: GRACZYK EVELYNE MARIE JEANNE.Datos registrales. T 28150 , F 179, S 8, H M 507135, I/A 4 (15.11.11).
29 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: LASIERRA SUELVES MANUEL. Datos registrales. T 28150 , F 179, S 8, H M 507135, I/A 3 (18.03.11).
22 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. C/ AZOR, NUMERO 24, POLIGONO INDUSTRIAL LOS GALLEG (FUENLABRADA). Datosregistrales. T 28150 , F 160, S 8, H M 507135, I/A 2 (10.11.10).
04 de Noviembre de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41889 , F 52, S 8, H B 139009, I/A 31 (21.10.10).
Nombramientos. APODERADO: FABIENNE MARIE ODILE BUCLET. Datos registrales. T 41889 , F 52, S 8, H B 139009, I/A 32(21.10.10).
06 de Octubre de 2010Nombramientos. APODERADO: NELLY CATHERINE NICOD;FABIANNE MARIE ODILE BUCLET;FRANCOIS WILLIAMQUASIMODO. Datos registrales. T 41889 , F 51, S 8, H B 139009, I/A 30 (23.09.10).
20 de Mayo de 2010Nombramientos. APODERADO: RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO;WILLIAMS MARK WILLIS JONES. Datos registrales. T 41889 , F51, S 8, H B 139009, I/A 29 ( 7.05.10).
28 de Septiembre de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29062 , F 150, S 8, H B 139009, I/A 27 (15.09.09).
Revocaciones. CONSEJERO: NICHOLAS JOHN BUCKINGHAM. Nombramientos. CONSEJERO: GUNTER KLAUS EVERINK.Datos registrales. T 29062 , F 150, S 8, H B 139009, I/A 28 (15.09.09).
19 de Agosto de 2009Revocaciones. CONSEJERO: SERGE GERARD MARCEL LUCIEN THIERRY. PRESIDENTE: SERGE GERARD MARCEL LUCIENTHIERRY. Nombramientos. CONSEJERO: ALBERT RUSSELL MITCHEL. PRESIDENTE: ALBERT RUSSELL MITCHEL. Datosregistrales. T 29062 , F 150, S 8, H B 139009, I/A 26 ( 6.08.09).