Buscador CIF Logo

Actos BORME Arr Maz Global Holdings Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arr Maz Global Holdings Sl

Actos BORME Arr Maz Global Holdings Sl - B84774603

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Arr Maz Global Holdings Sl con CIF B84774603

🔙 Perfil de Arr Maz Global Holdings Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Arr Maz Global Holdings Sl

06 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: LUEPTOW RONALD S.;KESELICA DAVID SCOTT. Nombramientos. Apo.Manc.: CUBERES MALLOLJOSEP MARIA;CAMPANELLA NICK;PAREJO CASTRO MARIA JOSEFA;GAINOUS TINA SMITH. Apo.Sol.: CUBERES MALLOLJOSEP MARIA. Datos registrales. T 35439 , F 64, S 8, H M 413056, I/A 21 (30.08.22).

09 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL;MARTINEZ- MERELLO DIAZ DE MIRANDAPATRICIA-PILAR. Presidente: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL. Vicepresid.: MARTINEZ- MERELLO DIAZ DEMIRANDA PATRICIA-PILAR. Con.Delegado: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL. Consejero: TAIEB ARIE MAX.Nombramientos. Consejero: KATZ EMANUEL TOBY. Presidente: KATZ EMANUEL TOBY. Consejero: CUBERES MALLOL JOSEPMARIA. Vicepresid.: CUBERES MALLOL JOSEP MARIA. Consejero: DURAND-DELACRE XAVIER JEAN JOSEPH. Con.Delegado:KATZ EMANUEL TOBY. Datos registrales. T 35439 , F 63, S 8, H M 413056, I/A 20 ( 2.03.22).

15 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MENDEZ BUSHELL DE MARCO GERMAN. Consejero: PIERRE LEPINAY FREDERIQUEMARIE. Nombramientos. Secretario: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Consejero: TAIEB ARIE MAX. Datos registrales. T 35439 , F 63, S8, H M 413056, I/A 19 ( 8.06.21).

26 de Octubre de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ARRMAZ PRODUCTS INC. Datos registrales. T 35439 , F 62, S 8,H M 413056, I/A 18 (19.10.20).

28 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: INTERTRUST (SPAIN) SL;KESELICA DAVID SCOTT. Presidente: KESELICA DAVID SCOTT.Consejero: LUEPTOW RONALD S. Vicepresid.: INTERTRUST (SPAIN) SL. Secretario: LUEPTOW RONALD S. Con.Delegado:KESELICA DAVID SCOTT. VsecrNoConsj: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Representan: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN.Nombramientos. Consejero: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL;MARTINEZ- MERELLO DIAZ DE MIRANDAPATRICIA-PILAR;PIERRE LEPINAY FREDERIQUE MARIE. Presidente: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL.Vicepresid.: MARTINEZ- MERELLO DIAZ DE MIRANDA PATRICIA-PILAR. SecreNoConsj: MENDEZ BUSHELL DE MARCOGERMAN. VsecrNoConsj: FREIRE VILLANOVA ANA. Con.Delegado: MARCEL CHESNEAU JEAN-FRANCOIS ISMAEL. Datosregistrales. T 35439 , F 62, S 8, H M 413056, I/A 17 (21.08.20).

19 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41, PLANTA 4ª (MADRID). Datos registrales. T 35439 , F 61, S 8, H M 413056, I/A 16 (9.02.18).

17 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: INTERTRUST (SPAIN) SL. Nombramientos. Vicepresid.: INTERTRUST (SPAIN) SL. Secretario:LUEPTOW RONALD S. Con.Delegado: KESELICA DAVID SCOTT. VsecrNoConsj: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T35439 , F 61, S 8, H M 413056, I/A 15 ( 8.11.17).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: LUEPTOW RONALD S.;KESELICA DAVID SCOTT. Datos registrales. T 23055 , F 180, S 8, H M413056, I/A 14 (13.01.17).

14 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARTIN DANIEL JACKSON. Vicepresid.: PARTIN DANIEL JACKSON. Nombramientos. Consejero:LUEPTOW RONALD S. Datos registrales. T 23055 , F 180, S 8, H M 413056, I/A 13 ( 3.11.16).

09 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: WATERS FRANK L. Consejero: WATERS FRANK L. Con.Delegado: WATERS FRANK L.Nombramientos. Consejero: KESELICA DAVID SCOTT. Presidente: KESELICA DAVID SCOTT. Datos registrales. T 23055 , F 180,S 8, H M 413056, I/A 12 (29.04.14).

19 de Enero de 2011
Cambio de domicilio social. C/ HERMOSILLA, 11, 4 A. (MADRID). Datos registrales. T 23055 , F 180, S 8, H M 413056, I/A 10 (7.01.11).

Nombramientos. Vicepresid.: PARTIN DANIEL JACKSON. Apoderado: PARTIN DANIEL JACKSON. Datos registrales. T 23055 , F180, S 8, H M 413056, I/A 11 ( 7.01.11).

05 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: VARNADOE GLEN RICHARD. Presidente: VARNADOE GLEN RICHARD. Con.Delegado:VARNADOE GLEN RICHARD. Nombramientos. Presidente: WATERS FRANK L. Consejero: WATERS FRANK L. Con.Delegado:WATERS FRANK L. Datos registrales. T 23055 , F 179, S 8, H M 413056, I/A 9 (26.01.10).

28 de Agosto de 2009
Otros conceptos: EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTE HOJA: -FORTISINTERTRUST (SPAIN) SA-, HACAMBIADO SU DENOMINACION SOCIAL,SIENDO LA ACTUAL, -INTERTRUST (SPAIN) SA-. Datos registrales. T 23055 , F 173, S8, H M 413056, I/A 1-M (19.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información