Buscador CIF Logo

Actos BORME Arrando 10 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arrando 10 Sl

Actos BORME Arrando 10 Sl - B83336859

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Arrando 10 Sl con CIF B83336859

馃敊 Perfil de Arrando 10 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Arrando 10 Sl

12 de Noviembre de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA, 60, 8潞 (MADRID). Datos registrales. T 38350 , F 167, S 8, H M 307002,I/A 18 ( 4.11.21).

28 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ DEL TANAGO MARIA. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO GONZALEZDEL TANAGO MARIA. Datos registrales. T 38350 , F 166, S 8, H M 307002, I/A 17 (21.09.21).

12 de Enero de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ARAGONESAS PROMOCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONESSL. Datos registrales. T 38350 , F 164, S 8, H M 307002, I/A 15 ( 4.01.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA TORRE MU脩OZ JUAN CARLOS;BACHILLER MENDEZ JUAN BAUTISTA;LLADO ARBURUAJOSE MANUEL;DE LA TORRE MU脩OZ JUAN CARLOS;NAVARRO GONZALEZ DEL TANAGO MARIA. Nombramientos.Apoderado: NAVARRO GONZALEZ DEL TANAGO MARIA. Datos registrales. T 38350 , F 165, S 8, H M 307002, I/A 16 ( 4.01.21).

18 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA TORRE MU脩OZ JUAN CARLOS;BACHILLER MENDEZ JUAN BAUTISTA;LLADO ARBURUAJOSE MANUEL;DE LA TORRE MU脩OZ JUAN CARLOS;NAVARRO GONZALEZ DEL TANAGO MARIA. Datos registrales. T 17803 ,F 28, S 8, H M 307002, I/A 14 (11.02.19).

21 de Enero de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ARACORP VIVIENDAS SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: TEJERO MATEOMARIA LUISA;SANCHEZ ESTRELLA MARIA PALOMA. Nombramientos. Adm. Unico: LLADO ARBURUA PILAR. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 17803 , F28, S 8, H M 307002, I/A 13 (14.01.19).

08 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALOBOS GIMENEZ JOSE LUIS. Vicepresid.: VILLALOBOS GIMENEZ JOSE LUIS. Consejero:VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER. Presidente: VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER. Consejero: SANCHEZ ESTRELLA MARIA PALOMA.Secretario: VILLALOBOS GIMENEZ CARLOS. Revocaciones. Apoderado: TEJERO MATEO MARIA LUISA. Apo.Manc.: SANCHEZESTRELLA MARIA PALOMA;VILLALOBOS JIMENEZ JOSE LUIS;VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.:TEJERO MATEO MARIA LUISA;SANCHEZ ESTRELLA MARIA PALOMA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO ELARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 17803 , F 27, S 8, H M 307002, I/A 12 (30.09.15).

29 de Julio de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 509.998,80 Euros. Resultante Suscrito: 3.681.901,20 Euros. Datos registrales. T 17803 ,F 26, S 8, H M 307002, I/A 11 (19.07.13).

22 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER;VILLALOBOS GIMENEZ JOSE LUIS;VILLALOBOS GIMENEZCARLOS;VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ ESTRELLA MARIA PALOMA;VILLALOBOSJIMENEZ JOSE LUIS;VILLALOBOS GIMENEZ JAVIER. Datos registrales. T 17803 , F 25, S 8, H M 307002, I/A 10 (14.01.13).

16 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALOBOS GIMENEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ ESTRELLA MARIAPALOMA. Datos registrales. T 17803 , F 25, S 8, H M 307002, I/A 9 ( 3.07.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n