Buscador CIF Logo

Actos BORME Arriva Spain Holding Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arriva Spain Holding Sl

Actos BORME Arriva Spain Holding Sl - B28468924

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Arriva Spain Holding Sl con CIF B28468924

馃敊 Perfil de Arriva Spain Holding Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Arriva Spain Holding Sl

23 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SIBER JANA. Presidente: SIBER JANA. Nombramientos. Presidente: CENDRERO QUEROLANTONIO. Datos registrales. T 41061 , F 36, S 8, H M 61216, I/A 38 (16.09.22).

08 de Febrero de 2022
Nombramientos. Con.Delegado: CENDRERO QUEROL ANTONIO. Datos registrales. T 41061 , F 36, S 8, H M 61216, I/A 37 (1.02.22).

02 de Febrero de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 29. DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 41061 ,F 35, S 8, H M 61216, I/A 36 (26.01.22).

26 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILCHES BERRUS FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: MARCOS SANCHEZFRANCISCO. Datos registrales. T 41061 , F 35, S 8, H M 61216, I/A 35 (19.11.21).

25 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: DEL MORAL SALCEDO ALVARO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CENDRERO QUEROLANTONIO;FERNANDEZ DE CORDOVA CERVERO ISABEL. Apo.Sol.: PICADO NIETO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj:RODRIGUEZ MARTINEZ CRISTINA ROSA. Apo.Man.Soli: DEL MORAL SALCEDO ALVARO;CENDRERO QUEROL ANTONIO.Apo.Sol.: PICADO NIETO JAVIER. Datos registrales. T 41061 , F 33, S 8, H M 61216, I/A 34 (18.11.21).

02 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ DE CORDOVA CERVERO ISABEL. Nombramientos. Consejero: DEL MORALSALCEDO ALVARO. Secretario: DEL MORAL SALCEDO ALVARO. Apoderado: CENDRERO QUEROL ANTONIO. Datosregistrales. T 41061 , F 33, S 8, H M 61216, I/A 33 (25.10.21).

26 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ LAS FRAGUAS 27 (ALCORCON). Datos registrales. T 12279 , F 134, S 8, H M 61216, I/A 31(19.11.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL MORAL SALCEDO ALVARO;MARCOS SANCHEZ FRANCISCO MANUEL. Datos registrales.T 41061 , F 30, S 8, H M 61216, I/A 32 (19.11.20).

25 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA;CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES. Presidente:CENDRERO QUEROL ANTONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES. Apo.Sol.: MARQUESBRANCO DA SILVA LILIANA. Apoderado: MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA;CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES.Nombramientos. Consejero: SIBER JANA;VILCHES BERRUS FRANCISCO JAVIER. Presidente: SIBER JANA. Datos registrales. T12279 , F 134, S 8, H M 61216, I/A 30 (18.09.20).

19 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ PI脩A JUAN MANUEL. Presidente: MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA.

23 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MEDIALDEA RAMOS VICTOR. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ DE CORDOVACERVERO ISABEL. Datos registrales. T 12279 , F 132, S 8, H M 61216, I/A 28 (16.09.19).

29 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Presidente: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO.Con.Delegado: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO.Nombramientos. Consejero: CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES. Presidente: MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA.Datos registrales. T 12279 , F 131, S 8, H M 61216, I/A 27 (22.07.19).

29 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SABIN REINA JOSE MARIA. Datos registrales. T 12279 , F 131, S 8, H M 61216, I/A 25 (22.01.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SABIN REINA JOSE MARIA;REGIDOR AGUILAR EDUARDO FERNANDO. Apoderado: SABIN REINAJOSE MARIA;REGIDOR AGUILAR EDUARDO FERNANDO. Datos registrales. T 12279 , F 131, S 8, H M 61216, I/A 26 (22.01.19).

18 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: SABIN REINA JOSE MARIA;MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA. Nombramientos. Apoderado:MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA;SABIN REINA JOSE MARIA;GOMEZ PI脩A JUAN MANUEL;REGIDOR AGUILAR EDUARDOFERNANDO;MEDIALDEA RAMOS VICTOR;CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 12279 , F 129, S 8, HM 61216, I/A 24 (10.10.18).

25 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA.Nombramientos. SecreNoConsj: MEDIALDEA RAMOS VICTOR. Consejero: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;MARQUESBRANCO DA SILVA LILIANA;SABIN REINA JOSE MARIA;GOMEZ PI脩A JUAN MANUEL. Presidente: GARCIA DE MIGUEL JUANIGNACIO. Con.Delegado: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 25, 28 y 29de los Estatutos.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 12279 , F 128, S 8, H M 61216, I/A 23 (18.09.18).

23 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA. Datos registrales. T12279 , F 127, S 8, H M 61216, I/A 22 (14.02.18).

20 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: SABIN REINA JOSE MARIA;GOMEZ PI脩A JUAN MANUEL;REGIDOR AGUILAR EDUARDOFERNANDO;CASTRO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 12279 , F 126, S 8, H M 61216, I/A 21 (12.06.17).

12 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ESFERA UNIVERSAL SL. Representan: MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA.Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;MARQUES BRANCO DA SILVA LILIANA. Modificacionesestatutarias. Se modifica el articulo 25 de los estatutos sociales. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 45 (MADRID). Datosregistrales. T 12279 , F 125, S 8, H M 61216, I/A 19 ( 4.04.17).

Revocaciones. Apoderado: BLANCO CONDE ALFONSO;FUENTES RAMIREZ JAVIER. Datos registrales. T 12279 , F 125, S 8, HM 61216, I/A 20 ( 4.04.17).

15 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: FUENTES RAMIREZ JAVIER. Nombramientos. Representan: MARQUES BRANCO DA SILVALILIANA. Datos registrales. T 12279 , F 124, S 8, H M 61216, I/A 18 ( 6.02.17).

03 de Diciembre de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED. Datos registrales. T 12279 , F124, S 8, H M 61216, I/A 17 (24.11.14).

20 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: FUENTES RAMIREZ JAVIER;GARCIA BAILE ESTRELLA;FUENTES RAMIREZ JUAN CARLOS.Nombramientos. Apoderado: BLANCO CONDE ALFONSO;FUENTES RAMIREZ JAVIER;SABIN REINA JOSE MARIA;MARQUESBRANCO DA SILVA LILIANA. Datos registrales. T 12279 , F 123, S 8, H M 61216, I/A 16 (12.11.14).

14 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: WILLIAMSON JAMES ANTHONY. Nombramientos. Representan: FUENTES RAMIREZ JAVIER.Datos registrales. T 12279 , F 122, S 8, H M 61216, I/A 15 ( 3.10.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n