Buscador CIF Logo

Actos BORME Arsatur Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Arsatur Sa

Actos BORME Arsatur Sa - A43022177

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Tarragona para Arsatur Sa con CIF A43022177

馃敊 Perfil de Arsatur Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Tarragona

Actos BORME de Arsatur Sa

25 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: SABATER GAY MARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: SASTRE SABATER CONRADO.Presidente: SASTRE SABATER CONRADO. Datos registrales. T 948 , F 116, S 8, H T 7275, I/A 31 (18.01.23).

07 de Junio de 2022
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 141.475,40 Euros. Desembolsado: 141.475,40 Euros. Resultante Suscrito: 237.935,90 Euros.Resultante Desembolsado: 237.935,90 Euros. Datos registrales. T 948 , F 115, S 8, H T 7275, I/A 30 (31.05.22).

06 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES. Presidente: SABATER GAY MARIA DOLORES. Consejero:SASTRE RASPALL JORGE. Secretario: SASTRE RASPALL JORGE. Consejero: BOFILL MONTORO ANA MARIA. Nombramientos.Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES. Presidente: SABATER GAY MARIA DOLORES. Consejero: SASTRE RASPALLJORGE. Secretario: SASTRE RASPALL JORGE. Consejero: BONFILL MONTORO ANA MARIA. Datos registrales. T 948 , F 115, S8, H T 7275, I/A 29 (29.09.20).

09 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: ORRIOLS GASSIOT JOAN. Datos registrales. T 948 , F 114, S 8, H T 7275, I/A 28 ( 2.10.19).

21 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Gerente: BRUGADA CASULA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 948 , F 114, S 8, H T 7275, I/A 27(14.06.17).

05 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES. Presidente: SABATER GAY MARIA DOLORES. Consejero:SASTRE RASPALL ALFONSO. Secretario: SASTRE RASPALL ALFONSO. Consejero: BOFILL MONTORO ANA MARIA;ARANSSERRAMIA EMILIO. Nombramientos. Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES. Presidente: SABATER GAY MARIADOLORES. Consejero: SASTRE RASPALL JORGE. Secretario: SASTRE RASPALL JORGE. Consejero: BOFILL MONTORO ANAMARIA. Datos registrales. T 948 , F 75, S 8, H T 7275, I/A 26 (28.11.14).

31 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apoderado: SASTRE SABATER CONRADO. Datos registrales. T 948 , F 74, S 8, H T 7275, I/A 25 (24.03.14).

20 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Gerente Uni.: ARANS CHARLES JORGE. Revocaciones. Apoderado: ARANS CHARLES JORDI. Datosregistrales. T 948 , F 74, S 8, H T 7275, I/A 23 ( 5.05.10).

Nombramientos. Gerente: BRUGADA CASULA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 948 , F 74, S 8, H T 7275, I/A 24(11.05.10).

15 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SASTRE COSTA JORGE. Presidente: SASTRE COSTA JORGE. Consejero: SASTRE RASPALLALFONSO. Secretario: SASTRE RASPALL ALFONSO. Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES;ARANS SERRAMIA EMILIO.Nombramientos. Consejero: SABATER GAY MARIA DOLORES. Presidente: SABATER GAY MARIA DOLORES. Consejero:SASTRE RASPALL ALFONSO. Secretario: SASTRE RASPALL ALFONSO. Consejero: BOFILL MONTORO ANA MARIA;ARANSSERRAMIA EMILIO. Datos registrales. T 948 , F 73, S 8, H T 7275, I/A 22 ( 1.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n