Actos BORME de Artedo Motor Sl
27 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOLIS PAULA. Datos registrales. T 32418 , F 51, S 8, H M 583509, I/A 24 (19.12.23).
13 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: CUERVO MOSTEIRIN ANA-ESTRELLA;ZUAZUA TOSAL MARIA. Datos registrales. T 32418 , F 51, S8, H M 583509, I/A 22 ( 3.11.23).
Nombramientos. Apoderado: CUERVO MOSTEIRIN ANA-ESTRELLA;FERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTINA. Datos registrales. T32418 , F 51, S 8, H M 583509, I/A 23 ( 3.11.23).
15 de Junio de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 218.780,10 Euros. Resultante Suscrito: 544.500,00 Euros. Datos registrales. T 32418 , F 50, S 8, HM 583509, I/A 21 ( 8.06.23).
28 de Octubre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 263.357,55 Euros. Resultante Suscrito: 325.719,90 Euros. Datos registrales. T 32418 , F50, S 8, H M 583509, I/A 20 (21.10.22).
12 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 32418 , F 49, S 8, H M 583509, I/A 19 ( 5.09.22).
07 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: DIEZ VALDES MIGUEL. Datos registrales. T 32418 , F 49, S 8, H M 583509, I/A 18 (30.06.22).
10 de Febrero de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 196.704,00 Euros. Resultante Suscrito: 189.072,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 400.005,45 Euros. Resultante Suscrito: 589.077,45 Euros. Datos registrales. T 32418 , F 49, S 8, H M 583509, I/A 17 (3.02.22).
12 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 32418 , F 49, S 8, H M 583509, I/A 16 (5.02.21).
07 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: DIEZ VALDES MIGUEL. Datos registrales. T 32418 , F 48, S 8, H M 583509, I/A 15 (31.03.20).
19 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: ARDIT DIAZ LUIS-ANGEL. Datos registrales. T 32418 , F 48, S 8, H M 583509, I/A 13 (12.02.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSOPURIFICACION. Reelecciones. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T32418 , F 48, S 8, H M 583509, I/A 14 (12.02.20).
04 de Febrero de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 305.424,00 Euros. Resultante Suscrito: 385.776,00 Euros. Datos registrales. T 32418 , F47, S 8, H M 583509, I/A 12 (28.01.20).
24 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 32418 , F 47, S 8, H M 583509, I/A 11(17.01.18).
15 de Enero de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: CUERVO MOSTEIRIN ANA-ESTRELLA;ZUAZUA TOSAL MARIA. Datos registrales. T 32418 , F 46, S8, H M 583509, I/A 10 ( 5.01.16).
02 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: ASOCIACION NACIONAL ESPA脩OLA DE CONCESIONARIOS FIA;RUBIO FERNANDEZSERGIO;RODRIGUEZ PUELO ARTURO. Datos registrales. T 32418 , F 46, S 8, H M 583509, I/A 9 (23.09.15).
27 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 32418 , F 45, S 8, H M 583509, I/A 7 (17.04.15).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 32418 , F 45, S 8, H M 583509, I/A 8 (17.04.15).
04 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: E.B. AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 32418 , F 45, S 8, H M 583509, I/A 6 (28.01.15).
15 de Enero de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AUTOMOVILES PORCEYO SL. Datos registrales. T 32418 , F 43, S 8, H M583509, I/A 5 ( 7.01.15).
28 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 32418 , F 42, S 8, H M 583509, I/A 3 (21.07.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO FERNANDEZ SERGIO;ZUAZUA TOSAL MARIA;LISTE SANCHEZ JUAN JOSE. Datosregistrales. T 32418 , F 43, S 8, H M 583509, I/A 4 (21.07.14).
30 de Junio de 2014Cambio de domicilio social. C/ GENERAL ARRANDO - NUMERO 9-BIS, BAJO (MADRID). Datos registrales. T 32418 , F 42, S 8,H M 583509, I/A 2 (20.06.14).