Actos BORME de Artenay Internacional Sl
12 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: MONJO SACRISTAN PALOMA. Apo.Sol.: GUZMAN CONDADO ENRIQUE;DEL PINO MARTINEZ JOSEMANUEL;CARRASCO RASO JESUS. Datos registrales. T 29793 , F 92, S 8, H M 536027, I/A 12 ( 5.07.19).
23 de Mayo de 2018Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 2 (MADRID). Datos registrales. T 29793 , F 92, S 8, H M536027, I/A 11 (16.05.18).
20 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GALAN CARLOS. Datos registrales. T 29793 , F 91, S 8, H M 536027, I/A 9 (13.12.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRASCO RASO JESUS. Datos registrales. T 29793 , F 91, S 8, H M 536027, I/A 10 (13.12.17).
31 de Mayo de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DELAVIUDA CONFECTIONERY GROUP SL. Datos registrales. T 29793 , F 91, S8, H M 536027, I/A 8 (24.05.17).
09 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;LOPEZ DONAIRE MANUEL. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO.Consejero: SEDA CEREALES SL. Vicepresid.: SEDA CEREALES SL. Con.Delegado: LOPEZ DONAIRE MANUEL. SecreNoConsj:SANCHEZ RUIZ ISABEL. Representan: GOMEZ BILBAO I脩IGO. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ DONAIRE MANUEL. Otros
20 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GALAN CARLOS. Datos registrales. T 29793 , F 90, S 8, H M 536027, I/A 6 (11.08.14).
17 de Marzo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.453.271,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Fechade Cierre de Ejercicio: 30/6. nueva redacci贸n del art铆culo 19 de los estatutos . Datos registrales. T 29793 , F 89, S 8, H M 536027, I/A5 ( 6.03.14).
25 de Abril de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 20.436.889,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.453.271,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.453.271,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞.Capital.-.Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital.-. Datos registrales. T 29793 , F 87, S 8, H M 536027, I/A 4 (17.04.13).
16 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SERRANO MARTIN LUIS. Consejero: SERRANO MARTIN LUIS. Nombramientos. Consejero:SEDA CEREALES SL. Vicepresid.: SEDA CEREALES SL. Con.Delegado: LOPEZ DONAIRE MANUEL. Representan: GOMEZBILBAO I脩IGO. Datos registrales. T 29793 , F 87, S 8, H M 536027, I/A 3 ( 4.10.12).
30 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;LOPEZ DONAIRE MANUEL;SERRANO DIAZ LUIS. Presidente: LOPEZROJAS ALFREDO. Vicepresid.: SERRANO DIAZ LUIS. Nombramientos. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;LOPEZ DONAIREMANUEL;SERRANO MARTIN LUIS. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Vicepresid.: SERRANO MARTIN LUIS. Reelecciones.SecreNoConsj: SANCHEZ RUIZ ISABEL. Cambio de domicilio social. C/ JOSE BARDASANO BAOS 9 (MADRID). Datosregistrales. T 29793 , F 86, S 8, H M 536027, I/A 2 (18.04.12).
08 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.890.160,00 Euros. Datos registrales. T 1536 , F 138, S8, H TO 22916, I/A 15 (30.01.12).
Revocaciones. Apoderado: MAZA CIORDIA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1536 , F 138, S 8, H TO 22916, I/A 16(30.01.12).
24 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.387.154,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.390.160,00 Euros. Datos registrales. T 1488 , F 20, S8, H TO 22916, I/A 12 (16.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ DONAIRE MANUEL;LOPEZ ROJAS ALFREDO. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO.Consejero: SERRANO MARTIN LUIS. Vicepresid.: SERRANO DIAZ LUIS. Consejero: SERRANO DIAZ LUIS. SecreNoConsj:SANCHEZ RUIZ ISABEL. Nombramientos. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;LOPEZ DONAIRE MANUEL;SERRANO DIAZLUIS. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Vicepresid.: SERRANO DIAZ LUIS. SecreNoConsj: SANCHEZ RUIZ ISABEL. Datosregistrales. T 1536 , F 137, S 8, H TO 22916, I/A 13 (16.01.12).
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ DONAIRE MANUEL;SERRANO DIAZ RAUL. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DONAIREMANUEL. Datos registrales. T 1536 , F 137, S 8, H TO 22916, I/A 14 (16.01.12).
11 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Consejero: LOPEZ DONAIREMANUEL;SERRANO MARTIN LUIS. Vicepresid.: SERRANO MARTIN LUIS. Consejero: MAZA CIORDIA JUAN. Revocaciones.Secretario: SANCHEZ RUIZ ISABEL. Nombramientos. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;SERRANO MARTIN LUIS;LOPEZDONAIRE MANUEL;SERRANO DIAZ LUIS. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Vicepresid.: SERRANO DIAZ LUIS.SecreNoConsj: SANCHEZ RUIZ ISABEL. Datos registrales. T 1488 , F 20, S 8, H TO 22916, I/A 10 (27.12.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUZMAN CONDADO ENRIQUE;DEL PINO MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1488 , F20, S 8, H TO 22916, I/A 11 (27.12.10).
01 de Febrero de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ DONAIRE MANUEL;SERRANO DIAZ RAUL. Datos registrales. T 1484 , F 86, S 8, H TO22916, I/A 8 (15.01.10).
Nombramientos. Apoderado: MAZA CIORDIA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1488 , F 19, S 8, H TO 22916, I/A 9 (15.01.10).
13 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.003.006,00 Euros. Datos registrales. T 1484 , F 85, S8, H TO 22916, I/A 7 (30.12.09).
23 de Noviembre de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1296 , F 120, S 8, H TO 22916, I/A 5 (12.11.09).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SERRANO DIAZ ELISA. Nombramientos. Consejero: LOPEZ ROJAS ALFREDO;SERRANOMARTIN LUIS;LOPEZ DONAIRE MANUEL;MAZA CIORDIA JUAN. Presidente: LOPEZ ROJAS ALFREDO. Vicepresid.: SERRANOMARTIN LUIS. Secretario: SANCHEZ RUIZ ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ REAL 103 (AJOFRIN). Datos registrales. T 1296, F 120, S 8, H TO 22916, I/A 6 (12.11.09).
06 de Noviembre de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SEDA CEREALES SL. Datos registrales. T 1296 , F 120, S 8, H TO 22916, I/A 4(26.10.09).