Actos BORME de Arteovo Sl
26 de Diciembre de 2019Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 721, L 512, F 218, S 8, H BU 13686, I/A 27 (18.12.19).
26 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: CASA脩 GIL DAVID. Nombramientos. Apo.Sol.: ZAPATA LOZANO ROBERTO. Datos registrales. T 721,L 512, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 26 (20.02.19).
03 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ARANO ECHEBARRIA JOSEBA;CARNERO FERNANDEZ JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALODIAZ CRISTINA;URCELAY IGARTUA LUCIA;MARTIN GONZALEZ EMILIO;ESPINOSA SALAZAR ANTONIO. Datos registrales. T721, L 512, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 25 (20.12.18).
21 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 721, L 512, F 217, S 8, H BU13686, I/A 24 (14.12.18).
16 de Enero de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CALIDAD PASCUAL SA. Datos registrales. T 721, L 512, F 216, S8, H BU 13686, I/A 23 (10.01.18).
27 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 193, S 8, H BU13686, I/A 22 (19.12.17).
14 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 193, S 8, H BU13686, I/A 21 ( 7.02.17).
21 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVAROCARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SAIZ RAMIREZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: DE LA CALLE ARMESTO DAVID. Apo.Man.Soli: MARTINGONZALEZ EMILIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSO OCTAVIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOTINMARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SAIZ RAMIREZJOSE LUIS. Apo.Sol.: CASA脩 GIL DAVID. Apo.Man.Soli: MARTIN GONZALEZ EMILIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZALONSO OCTAVIO. Datos registrales. T 695, L 486, F 193, S 8, H BU 13686, I/A 20 (15.12.16).
25 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO;PASCUAL GOMEZ CUETARASONIA;PASCUAL GOMEZ CUETARA MARIA DEL PILAR;PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Presidente: PASCUALGOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Nombramientos. Adm.Unico: PASCUAL GESTION Y GOBIERNO SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administrador 煤nico. Datos registrales. T 695, L 486, F 191, S 8, H BU 13686, I/A 19 (18.10.16).
20 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZRUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;GARCIA-CANO SALGADO IGNACIO. Apo.Sol.: DE LA CALLEARMESTO DAVID. Apo.Man.Soli: CASTA脩EDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSOOCTAVIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVAROCARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SAIZ RAMIREZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: DE LA CALLE ARMESTO DAVID. Apo.Man.Soli: MARTINGONZALEZ EMILIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSO OCTAVIO. Datos registrales. T 695, L 486, F 190, S 8, HBU 13686, I/A 18 (13.07.16).
25 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 189, S 8, H BU13686, I/A 17 (19.01.16).
26 de Octubre de 2015Otros conceptos: Modificaci贸n de Estatutos Sociales de la sociedad, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas enla Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre. Ampliacion del objeto social. La producci贸n, envasado,comercializaci贸n y distribuci贸n de productos derivados del huevo.Compraventa de materias primas para la fabricaci贸n de productoscon base de huevo. Datos registrales. T 650, L 441, F 59, S 8, H BU 13686, I/A 16 (20.10.15).
19 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S 8, H BU 13686,I/A 15 (13.01.15).
12 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA SONIA. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCOBORJA. Nombramientos. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S8, H BU 13686, I/A 14 ( 5.08.14).
24 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S 8, H BU 13686,I/A 13 (17.12.13).
04 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Nombramientos. Apoderado: PASCUALGOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Datos registrales. T 650, L 441, F 57, S 8, H BU 13686, I/A 12 (25.06.12).
18 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZRUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;GARCIA-CANO SALGADO IGNACIO. Apo.Sol.: DE LA CALLEARMESTO DAVID. Apo.Man.Soli: CASTA脩EDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSOOCTAVIO. Datos registrales. T 626, L 417, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 10 ( 7.06.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GORRIZ MORENOFRANCISCO;CASTA脩EDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSO OCTAVIO;GARRIDO SAINZRUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SOBLECHERO PASCUAL ENRIQUE;ARRANZ NU脩EZ JESUS.Datos registrales. T 650, L 441, F 57, S 8, H BU 13686, I/A 11 ( 7.06.12).
17 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ARANO ECHEBARRIA JOSEBA;CARNERO FERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 626, L 417, F217, S 8, H BU 13686, I/A 9 ( 9.06.11).
05 de Mayo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 840.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 984.429,00 Euros. Datos registrales. T 626, L 417, F 215, S8, H BU 13686, I/A 8 (25.04.11).
04 de Abril de 2011Fe de erratas: Por diligencia incorporada a la escritura que caus贸 la inscripci贸n 3&, se rectifica el DNI del apoderado DON ANTONIOCASTILLA COBO, siendo el correcto 13.066.751-Z. Datos registrales. T 626, L 417, F 215, S 8, H BU 13686, I/A 7 (24.03.11).
04 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 624, L 415, F 170, S 8, H BU13686, I/A 6 (26.01.11).
26 de Enero de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL S.L. Datosregistrales. T 624, L 415, F 170, S 8, H BU 13686, I/A 5 (17.01.11).
28 de Septiembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 141.329,00 Euros. Resultante Suscrito: 144.429,00 Euros. Datos registrales. T 622, L 413, F 19, S8, H BU 13686, I/A 4 (17.09.10).
06 de Julio de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.05.10. Objeto social: Fabricaci贸n,importaci贸n,exportaci贸n decereales,conservas,vegetales y animales.Compraventa,arrendamiento de fincas r煤sticas-urbanas con destino agricola,ganaderoforestal.Fabricaci贸n,importaci贸n, exportaci贸n,de maquinaria, utillaje,alimentaci贸n y hosteler铆a.Explotaci贸n de transportes terrestres.Domicilio: CTRA PALENCIA S/N (ARANDA DE DUERO). Capital: 3.100,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:GRUPO LECHE PASCUAL SA. Nombramientos. Consejero: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO;PASCUALGOMEZ CUETARA SONIA;PASCUAL GOMEZ CUETARA MARIA DEL PILAR;PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA.Datos registrales. T 622, L 413, F 11, S 8, H BU 13686, I/A 1 (25.06.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GORRIZ MORENOFRANCISCO;CASTA脩EDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSO OCTAVIO;GARRIDO SAINZRUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SOBLECHERO PASCUAL ENRIQUE;ARRANZ NU脩EZ JESUS.Datos registrales. T 622, L 413, F 15, S 8, H BU 13686, I/A 3 (25.06.10).
Nombramientos. Presidente: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARAFRANCISCO BORJA. VsecrNoConsj: CASTA脩EDA CAMARERO ANTONIO. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMASFLORENCIO. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA SONIA. Datos registrales. T 622, L 413, F 15, S 8, H BU 13686, I/A 2(25.06.10).