Buscador CIF Logo

Actos BORME Ascia Eas Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ascia Eas Sa

Actos BORME Ascia Eas Sa - A29351525

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ascia Eas Sa con CIF A29351525

🔙 Perfil de Ascia Eas Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ascia Eas Sa

04 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: BURZO LIVIA. Datos registrales. T 25790 , F 160, S 8, H M 136580, I/A 63 (25.04.23).

12 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 160, S 8, H M 136580, I/A 62 (5.08.22).

28 de Julio de 2021
Reelecciones. Auditor: MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 160, S 8, H M 136580, I/A 61(21.07.21).

01 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BURZO LIVIA;PIZARRO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN;ALONSO MARTINEZ CRISTOBAL.Nombramientos. Apoderado: PIZARRO SANCHEZ MARIA CARMEN. Datos registrales. T 25790 , F 157, S 8, H M 136580, I/A 60(22.02.21).

05 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 157, S 8, H M 136580,I/A 59 (28.09.20).

09 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Consejero: CORCHADO QUILEZ JOSE ANTONIO. Presidente: CORCHADO QUILEZ JOSE ANTONIO. Consejero:SANTAOLALLA LOPEZ CARLOS MARIA. Secretario: SANTAOLALLA LOPEZ CARLOS MARIA. Cons.Del.Sol: CORCHADO QUILEZJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 25790 , F 156, S 8, H M 136580, I/A 58 ( 2.09.20).

13 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUILEZ MARTINEZ DE LA VEGA MARIA DEL PINO. Nombramientos. Consejero: PIZARROSANCHEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 25790 , F 156, S 8, H M 136580, I/A 56 ( 6.09.19).

Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 156, S 8, H M 136580,I/A 57 ( 6.09.19).

31 de Agosto de 2018
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 141.347,88 Euros. Datos registrales. T 25790 , F 155, S 8, H M 136580, I/A55 (24.08.18).

27 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 155, S 8, H M 136580,I/A 54 (20.08.18).

17 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: CAMPRODON ALBERCA CARLOS. Datos registrales. T 25790 , F 155, S 8, H M 136580, I/A 53 (9.04.18).

07 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 155, S 8, H M 136580,I/A 51 (30.10.17).

Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 155, S 8, H M 136580,I/A 52 (30.10.17).

26 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 154, S 8, H M 136580,I/A 50 (18.10.17).

03 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BURZO LIVIA;ALONSO MARTINEZ CRISTOBAL. Datos registrales. T 25790 , F 152, S 8, H M136580, I/A 48 (26.09.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BURZO LIVIA;PIZARRO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN;ALONSO MARTINEZ CRISTOBAL.Datos registrales. T 25790 , F 152, S 8, H M 136580, I/A 49 (26.09.17).

30 de Agosto de 2017
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA ADAPTARLOS A LA VIGENTE LEY DESOCIEDADES DE CAPITAL.. Datos registrales. T 25790 , F 149, S 8, H M 136580, I/A 47 (22.08.17).

04 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: BAGUENA ROMEU DAVID;SANMARTIN ANTELO MANUEL;GARCIA DE PAADIN RIVERA ALFONSOJOSE Datos registrales. T 25790 , F 147, S 8, H M 136580, I/A 45 (28.08.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BURZO LIVIA;ALONSO MARTINEZ CRISTOBAL. Datos registrales. T 25790 , F 147, S 8, H M136580, I/A 46 (28.08.14).

07 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25790 , F 147, S 8, H M 136580,I/A 44 (28.07.14).

24 de Julio de 2014
Reelecciones. Consejero: CORCHADO QUILEZ JOSE ANTONIO. Presidente: CORCHADO QUILEZ JOSE ANTONIO. Consejero:SANTAOLALLA LOPEZ CARLOS MARIA. Secretario: SANTAOLALLA LOPEZ CARLOS MARIA. Cons.Del.Sol: CORCHADO QUILEZJOSE ANTONIO. Consejero: QUILEZ MARTINEZ DE LA VEGA MARIA DEL PINO. Datos registrales. T 25790 , F 146, S 8, H M136580, I/A 43 (15.07.14).

10 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CONTRERAS HERRERO MARIA TERESA. Datos registrales. T 25790 , F 145, S 8, H M 136580, I/A42 ( 2.10.13).

20 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: BURZO LIVIA. Datos registrales. T 25790 , F 144, S 8, H M 136580, I/A 41 (10.05.13).

16 de Mayo de 2013
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 25790 , F 144, S 8, H M 136580, I/A40 ( 7.05.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información