Actos BORME de Asevi Asesores Vitoria SA
08 de Septiembre de 2020Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ASEVI ASESORES VITORIA, S.L. IVESA INVERSIONESINMOBILIARIAS, S.L. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 1606 , F 6, S 8, H VI 1779, I/A 33 (19.08.20).
20 de Marzo de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 24.749,18 Euros. Resultante Suscrito: 63.838,22 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Otros conceptos: Se renumeran las acciones que integran el capital social de lacompa帽铆a. Datos registrales. T 1606 , F 4, S 8, H VI 1779, I/A 31 ( 4.03.20).
08 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ MARIA BLANCA. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ FERNANDEZMARIA BLANCA. Datos registrales. T 1606 , F 4, S 8, H VI 1779, I/A 30 (15.04.19).
04 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS;GIL BERNAL ANTONIO;PORTILLOYABAR EDUARDO;GARCIA MACUA LUIS MARIA;LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO;ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI.Secretario: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO. Revocaciones. Apoderado: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZILDEFONSO JESUS. Apo.Sol.: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GUEMESTIMOTEO. Consejero: GONZALEZ GUEMES TIMOTEO. Secretario: GONZALEZ GUEMES TIMOTEO. Datos registrales. T 1606 , F3, S 8, H VI 1779, I/A 29 (26.11.18).
16 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Revocaciones. Apoderado: GARCIA MACUA LUIS MARIA.
18 de Agosto de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.981,28 Euros. Resultante Suscrito: 88.587,40 Euros. Otros conceptos: Comoconsecuencia de la reducci贸n de capital social se renumeran las acciones de la n潞 1 al 14.740, ambas inclusive. Datos registrales. T1606 , F 2, S 8, H VI 1779, I/A 26 ( 8.08.17).
15 de Abril de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.507,50 Euros. Resultante Suscrito: 96.568,68 Euros. Otros conceptos: Se renumeranlas acciones de la n潞 1 a la 16.068, ambos inclusive.- Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 24 ( 4.04.16).
11 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI. Nombramientos. Secretario: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZFERNANDO. Reelecciones. Consejero: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS;LOPEZ DE LUZURIAGAARAGOLAZA ALBERTO;GIL BERNAL ANTONIO;BERROCI HERRERIA BEGO脩A;PORTILLO YABAR EDUARDO;GARCIA MACUALUIS MARIA;LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO;ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI;GONZALEZ GUEMES TIMOTEO.Presidente: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 23 ( 1.06.15).
17 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: MONFORTE MARTINEZ MANUEL ANGEL;CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS.Nombramientos. Apoderado: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS. Datos registrales. T 729 , F 186, S 8, HVI 1779, I/A 20 ( 5.12.14).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 729 , F 186, S 8, H VI 1779, I/A 21 ( 5.12.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONFORTE MARTINEZ MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 22 (5.12.14).