Buscador CIF Logo

Actos BORME Asevi Asesores Vitoria SA

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Asevi Asesores Vitoria SA

Actos BORME Asevi Asesores Vitoria SA - A01041631

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Alava para Asevi Asesores Vitoria SA con CIF A01041631

馃敊 Perfil de Asevi Asesores Vitoria SA
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alava

Actos BORME de Asevi Asesores Vitoria SA

08 de Septiembre de 2020
Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ASEVI ASESORES VITORIA, S.L. IVESA INVERSIONESINMOBILIARIAS, S.L. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 1606 , F 6, S 8, H VI 1779, I/A 33 (19.08.20).

20 de Marzo de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 24.749,18 Euros. Resultante Suscrito: 63.838,22 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Otros conceptos: Se renumeran las acciones que integran el capital social de lacompa帽铆a. Datos registrales. T 1606 , F 4, S 8, H VI 1779, I/A 31 ( 4.03.20).

08 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ MARIA BLANCA. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ FERNANDEZMARIA BLANCA. Datos registrales. T 1606 , F 4, S 8, H VI 1779, I/A 30 (15.04.19).

04 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS;GIL BERNAL ANTONIO;PORTILLOYABAR EDUARDO;GARCIA MACUA LUIS MARIA;LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO;ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI.Secretario: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO. Revocaciones. Apoderado: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZILDEFONSO JESUS. Apo.Sol.: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GUEMESTIMOTEO. Consejero: GONZALEZ GUEMES TIMOTEO. Secretario: GONZALEZ GUEMES TIMOTEO. Datos registrales. T 1606 , F3, S 8, H VI 1779, I/A 29 (26.11.18).

16 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Revocaciones. Apoderado: GARCIA MACUA LUIS MARIA.

18 de Agosto de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.981,28 Euros. Resultante Suscrito: 88.587,40 Euros. Otros conceptos: Comoconsecuencia de la reducci贸n de capital social se renumeran las acciones de la n潞 1 al 14.740, ambas inclusive. Datos registrales. T1606 , F 2, S 8, H VI 1779, I/A 26 ( 8.08.17).

15 de Abril de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.507,50 Euros. Resultante Suscrito: 96.568,68 Euros. Otros conceptos: Se renumeranlas acciones de la n潞 1 a la 16.068, ambos inclusive.- Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 24 ( 4.04.16).

11 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI. Nombramientos. Secretario: LOPEZ DE OCARIZ OCARIZFERNANDO. Reelecciones. Consejero: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS;LOPEZ DE LUZURIAGAARAGOLAZA ALBERTO;GIL BERNAL ANTONIO;BERROCI HERRERIA BEGO脩A;PORTILLO YABAR EDUARDO;GARCIA MACUALUIS MARIA;LOPEZ DE OCARIZ OCARIZ FERNANDO;ECHEVARRIA ARABAOLAZA ANDONI;GONZALEZ GUEMES TIMOTEO.Presidente: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 23 ( 1.06.15).

17 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: MONFORTE MARTINEZ MANUEL ANGEL;CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS.Nombramientos. Apoderado: CORRES FERNANDEZ DE TROCONIZ ILDEFONSO JESUS. Datos registrales. T 729 , F 186, S 8, HVI 1779, I/A 20 ( 5.12.14).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MACUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 729 , F 186, S 8, H VI 1779, I/A 21 ( 5.12.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MONFORTE MARTINEZ MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 729 , F 187, S 8, H VI 1779, I/A 22 (5.12.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n