Actos BORME de Asfaltos Jaen Sociedad Limitada
02 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ RAMIRO ENRIQUE. Datos registrales. T 697 , F 183, S 8, H J 652, I/A 63 (26.10.23).
08 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: VALVERDE GARCIA MARIA DOLORES. Apo.Sol.: ROMERO GONZALEZ JOSE ANTONIO. Apoderado:PONCE MORENO SALVADOR. Datos registrales. T 460 , F 169, S 8, H J 652, I/A 62 ( 1.09.23).
19 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: VALVERDE GARCIA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 460 , F 168, S 8, H J 652, I/A 59(13.04.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: PONCE MORENO SALVADOR. Datos registrales. T 460 , F 169, S 8, H J 652, I/A 60 (13.04.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 460 , F 169, S 8, H J 652, I/A 61(13.04.23).
05 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 460 , F 168, S 8, H J 652, I/A 58(28.11.22).
10 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GERARD CHOISEL PHILIPPE;UGUET CANAL NURIA. Datos registrales. T 460 , F 167, S 8, H J 652,I/A 57 (29.07.22).
22 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 460 , F 167, S 8, H J 652, I/A 56(16.03.22).
29 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: VALVERDE GARCIA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 460 , F 166, S 8, H J 652, I/A 54(23.07.20).
03 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: TORRES NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 460 , F 166, S 8, H J 652, I/A 53 (26.02.20).
05 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 460 , F 166, S 8, H J 652, I/A 52(28.10.19).
16 de Octubre de 2019Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 460 , F 166, S 8, H J 652, I/A 51(10.10.19).
05 de Marzo de 2019Otros conceptos: Se modifica la forma de actuacion de los apoderados de la inscripci贸n 49陋 por la forma SOLIDARIA. Datosregistrales. T 460 , F 166, S 8, H J 652, I/A 51 (25.02.19).
11 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ OLIAS ROBERTO;FERNANDEZ CASAS RAFAEL EDUARDO;CORRALES GONZALEZFRANCISCO. Datos registrales. T 460 , F 164, S 8, H J 652, I/A 49 ( 4.02.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BURRIEL SUSANA. Datos registrales. T 460 , F 165, S 8, H J 652, I/A 50 ( 4.02.19).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PONCE MORENO SALVADOR. Datos registrales. T 460 , F 163, S 8, H J 652, I/A 47 (31.10.18).
Nombramientos. Apoderado: VALVERDE GARCIA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 460 , F 164, S 8, H J 652, I/A 48(31.10.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 46(12.02.18).
02 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DEL RIO MONICA. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 43 (27.01.17).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ CUENCA GREGORIA. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 44 (27.01.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORRALES GONZALEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 45(27.01.17).
06 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ OLIAS ROBERTO. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 42 (29.09.16).
14 de Marzo de 2016Cambio de domicilio social. C/ ESTEBAN RAMIREZ 2 6& - OFICINA C (JAEN). Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A41 ( 8.03.16).
24 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: AMAGO VERDUGO CARMEN. Datos registrales. T 460 , F 161, S 8, H J 652, I/A 40 (16.11.15).
04 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: CILLERUELO TROTTER JOSE ANGEL. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 39(25.02.15).
26 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: TORRES NAVARRO JOSE;ORTIZ RUIZ MANUEL. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A38 (19.03.14).
13 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: TORRES NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 37 ( 6.03.14).
18 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: TORRES NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 36 (12.12.13).
05 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ AYESTARAN JOSE MARIA. Apo.Man.Soli: EDMOND GRILLOT HERVE GABRIEL. Datosregistrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 35 (24.11.11).
01 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 33 (21.06.11).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 460 , F 160, S 8, H J 652, I/A 34 (21.06.11).
13 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: TORRES NAVARRO JOSE. Datos registrales. T 460 , F 159, S 8, H J 652, I/A 32 ( 4.05.10).
18 de Diciembre de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITAD. Datosregistrales. T 460 , F 159, S 8, H J 652, I/A 31 (10.12.09).
02 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA;TORRES NAVARROJOSE;EDMOND GRILLOT HERVE GABRIEL. Con.Delegado: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA.Presidente: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA. Nombramientos. Adm. Unico: PROBISATECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 460 , F 159, S 8, H J 652, I/A 30 (20.11.09).