Actos BORME de Asistemaq 3byf Sl
16 de Abril de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: MARCO GOMEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 36282 , F 57, S 8, H B 283519, I/A 13 (6.04.21).
11 de Septiembre de 2020Nombramientos. ADM.UNICO: MARCO RIBAS FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 36282 , F 56, S 8, H B 283519, I/A 12 (3.09.20).
24 de Agosto de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: PJFI 2013 SL. REPR.143 RRM: RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO. Datos registrales. T 36282 , F 56,S 8, H B 283519, I/A 11 (17.08.20).
27 de Octubre de 2017Revocaciones. REPR.143 RRM: FORMENTIN IBAÑEZ PEDRO JOSE. Nombramientos. REPR.143 RRM: RODRIGUEZ GARCIARODRIGO. Datos registrales. T 36282 , F 56, S 8, H B 283519, I/A 10 (20.10.17).
28 de Abril de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: BONO CARRERAS ALFONS. Nombramientos. ADM.UNICO: PJFI 2013 SL. REPR.143 RRM:FORMENTIN IBAÑEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 36282 , F 56, S 8, H B 283519, I/A 9 (20.04.17).
20 de Noviembre de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: BONO CARRERAS ALFONS;BOIXADOS ORTEGA JORGE. Nombramientos. ADM.UNICO:BONO CARRERAS ALFONS. Datos registrales. T 36282 , F 55, S 8, H B 283519, I/A 8 (13.11.15).
24 de Marzo de 2015Cambio de domicilio social. CL RAMON LLULL Num.2 (TERRASSA). Datos registrales. T 36282 , F 55, S 8, H B 283519, I/A 7(16.03.15).
05 de Marzo de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: BONO CARRERAS JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 36282 , F 55, S 8, H B 283519, I/A 6(26.02.15).
22 de Mayo de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: FARIAS MACHADO ANDRES. Datos registrales. T 36282 , F 55, S 8, H B 283519, I/A 5
08 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. PG INDUSTRIAL LA BORDA C/BORGES BLANQUES Num.12 (CALDES DE MONTBUI). Datosregistrales. T 36282 , F 55, S 8, H B 283519, I/A 4 (25.10.10).