Buscador CIF Logo

Actos BORME Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl

Actos BORME Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl - B36584787

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl con CIF B36584787

馃敊 Perfil de Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Asistencia Y Soluciones De Arquitectura E Ingenieria Sl

08 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Secretario: MARTINEZ SOLI脩O PABLO. Cons.Del.Man: ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL;OTERO RAJOYMARCOS. Presidente: OTERO RAJOY MARCOS. Consejero: OTERO RAJOY MARCOS;MARTINEZ SOLI脩O PABLO;GONZALEZREY BELEN;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 177, S 8, H PO 46177, I/A 18 (29.08.23).

31 de Marzo de 2023
Ampliaci贸n de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 68.000,00 Euros. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 177, S8, H PO 46177, I/A 17 (22.03.23).

07 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: ANALISIS Y CONTROL DE CUENTAS SLP. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 176, S 8, H PO 46177, I/A16 (30.01.23).

14 de Octubre de 2021
Ampliacion del objeto social. Explotaci贸n de la madera, Silvicultura y explotaci贸n forestal. La explotaci贸n de bosques, trabajos deforestaci贸n y realizaci贸n de trabajos y servicios de tipo forestal; repoblar y hacer trabajos silv铆colas, ingenier铆a de montes y forestal, I+Dforestal y silv铆cola; la corta, pela, tronzado, desembo. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 176, S 8, H PO 46177, I/A 15 ( 5.10.21).

18 de Octubre de 2019
Nombramientos. Auditor: ANALISIS Y CONTROL DE CUENTAS SLP. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 176, S 8, H PO 46177,I/A 14 ( 9.10.19).

29 de Julio de 2019
Reelecciones. Secretario: MARTINEZ SOLI脩O PABLO. Cons.Del.Man: ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL;OTERO RAJOYMARCOS. Presidente: OTERO RAJOY MARCOS. Consejero: OTERO RAJOY MARCOS;MARTINEZ SOLI脩O PABLO;GONZALEZREY BELEN;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 175, S 8, H PO 46177, I/A 13 (18.07.19).

18 de Julio de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 130.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.000,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: GESTION DE RECURSOS INDUSTRIALES Y MAQUINARIA SL. Datos registrales. T 3471, L 3471, F175, S 8, H PO 46177, I/A 12 ( 9.07.18).

06 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRADAS SOAGE ANGEL MANUEL. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 174, S 8, H PO 46177,I/A 11 (26.09.17).

07 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 174, S 8, H PO46177, I/A 10 (30.06.16).

09 de Septiembre de 2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL;GONZALEZ REY BELEN;OTERORAJOY MARCOS;FERRADAS SOAGE ANGEL MANUEL;MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO;MARTINEZ SOLI脩O PABLO.Presidente: OTERO RAJOY MARCOS. Cons.Del.Man: OTERO RAJOY MARCOS;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL. Secretario:MARTINEZ SOLI脩O PABLO. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ SOLI脩O PABLO. Cons.Del.Man: ACU脩A MARTINEZ JOSEMANUEL;OTERO RAJOY MARCOS. Presidente: OTERO RAJOY MARCOS. Consejero: MEDRA脩O FARI脩A MANUELANTONIO;FERRADAS SOAGE ANGEL MANUEL;OTERO RAJOY MARCOS;MARTINEZ SOLI脩O PABLO;GONZALEZ REYBELEN;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL. Otros conceptos: SE MODIFICA EL ARTICULO 6潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 3471, L 3471, F 174, S 8, H PO 46177, I/A 9 ( 3.09.15).

24 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 68.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 138.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DO CAMPI脩O, RUA DAS MAMOAS 20 -P (PONTEVEDRA). Datos registrales. T 3471, L 3471, F 173, S 8, H PO 46177, I/A 7 (16.09.14).

Reelecciones. Cons.Del.Man: ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL;OTERO RAJOY MARCOS. Datos registrales. T 3471, L 3471, F173, S 8, H PO 46177, I/A 8 (16.09.14).

04 de Junio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 70.000,00 Euros. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 173, S8, H PO 46177, I/A 6 (27.05.13).

04 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: FERRADAS SOAGEANGEL MANUEL. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ REY BELEN. Consejero: MEDRA脩O FARI脩A MANUELANTONIO;FERRADAS SOAGE ANGEL MANUEL;OTERO RAJOY MARCOS;MARTINEZ SOLI脩O PABLO;GONZALEZ REYBELEN;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL. Presidente: OTERO RAJOY MARCOS. Secretario: MARTINEZ SOLI脩O PABLO.Cons.Del.Man: OTERO RAJOY MARCOS;MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO;ACU脩A MARTINEZ JOSE MANUEL.

17 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: FERRADAS SOAGE ANGEL MANUEL. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 171, S 8, H PO 46177,I/A 4 ( 2.10.12).

14 de Septiembre de 2012
Cambio de domicilio social. LUGAR MARCON-VILLAFRANCA 15 1潞 (PONTEVEDRA). Datos registrales. T 3471, L 3471, F 171, S8, H PO 46177, I/A 3 ( 4.09.12).

18 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OTERO RAJOY MARCOS;MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO. Nombramientos. Adm.Unico: MEDRA脩O FARI脩A MANUEL ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3471, L 3471, F 170, S 8, H PO 46177, I/A 2 ( 8.03.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n