Buscador CIF Logo

Actos BORME Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social

Actos BORME Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social - G28556462

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social con CIF G28556462

馃敊 Perfil de Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica De Prevision Social

19 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Consejero: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS. Presidente: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS. Consejero:MU脩OZ-PEREA PI脩AR ANTONIO. Con.Delegado: MU脩OZ-PEREA PI脩AR ANTONIO. Datos registrales. T 42266 , F 108, S 8, H M263849, I/A 33 (12.12.22).

15 de Febrero de 2022
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MATA OROZCO FERNANDO;RODRIGUEZ SESMA CARLOS;ROLDANFERNANDEZ JULIO. Con.Ind.: SOLER DE LA MANO AGUSTIN MARIA. Vicepresid.: MATA OROZCO FERNANDO. Secretario:ROLDAN FERNANDEZ JULIO. Nombramientos. Cons.NO Ejec: MATA OROZCO FERNANDO. Vicepresid.: MATA OROZCOFERNANDO. Cons.NO Ejec: RODRIGUEZ SESMA CARLOS. Consejero: ROLDAN FERNANDEZ JULIO. Secretario: ROLDANFERNANDEZ JULIO. Con.Ind.: SOLER DE LA MANO AGUSTIN MARIA. Apoderado: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS. Cambiode domicilio social. PASEO DE LAS DELICIAS 48 - 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 42266 , F 107, S 8, H M 263849,I/A 32 ( 8.02.22).

08 de Noviembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Nueva redacci贸n de la totalidad de los estatutos sociales. Datos registrales. T 21179 , F 68, S 8, H M263849, I/A 25 (29.10.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA MARTINEZ MARIA TERESA;VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO. Datos registrales. T 38676 ,F 186, S 8, H M 263849, I/A 26 (29.10.21).

Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ SESMA CARLOS. Nombramientos. Secretario: ROLDAN FERNANDEZ JULIO.Modificaciones estatutarias. Nueva redacci贸n de la totalidad de los estatutos . Datos registrales. T 38676 , F 187, S 8, H M263849, I/A 27 (29.10.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RIBON PEDRO;PRIETO BATANERO EDUARDO. Vicepresid.: JIMENEZ RIBON PEDRO.Nombramientos. Vicepresid.: MATA OROZCO FERNANDO. Datos registrales. T 38676 , F 193, S 8, H M 263849, I/A 28(29.10.21).

Nombramientos. Consejero: MU脩OZ-PEREA PI脩AR ANTONIO;SOLER DE LA MANO AGUSTIN MARIA. Otros conceptos: ENJUNTA DE 26 DE ABRIL DE 2017 HAN QUEDADO RATIFICADOS COMO CONSEJEROS DON ANTONIO MU脩OZ-PEREA PI脩ARvigente hasta abril de 2022 Y DON AGUSTIN SOLER DE LA MANO vigente hasta abril de 2020. Datos registrales. T 38676 , F 193,S 8, H M 263849, I/A 29 (29.10.21).

Modificaciones estatutarias. Nueva redacci贸n de la totalidad de los estatutos . Datos registrales. T 38676 , F 194, S 8, H M263849, I/A 30 (29.10.21).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: JIMENEZ DOLERA JOSE. Reelecciones. Consejero: MATA OROZCOFERNANDO. Vicepresid.: MATA OROZCO FERNANDO. Consejero: ROLDAN FERNANDEZ JULIO. Secretario: ROLDANFERNANDEZ JULIO. Consejero: RODRIGUEZ SESMA CARLOS. Datos registrales. T 42266 , F 106, S 8, H M 263849, I/A 31(29.10.21).

04 de Mayo de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 22陋 EL NOMBRAMIENTO DE JULIO RONDAN FERNANDEZCOMO CONSEJERO, SIENDO LO CORRECTO JULIO ROLDAN FERNANDEZ. Datos registrales. T 21179 , F 65, S 8, H M 263849,I/A 22 ( 5.08.14).

16 de Marzo de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES S C. Datos registrales. T 21179 , F 67, S 8, H M 263849, I/A24 ( 8.03.16).

09 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 21179 , F 67, S 8, H M 263849, I/A 23(28.11.14).

13 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: RODRIGUEZ SESMA CARLOS. Nombramientos. Secretario: RODRIGUEZ SESMA CARLOS.Reelecciones. Consejero: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS;JIMENEZ RIBON PEDRO;RODRIGUEZ SESMA CARLOS;VAZQUEZRODRIGUEZ EMILIO;SORIA MARTINEZ MARIA TERESA;PRIETO BATANERO EDUARDO;MATA OROZCO FERNANDO;RONDANFERNANDEZ JULIO;JIMENEZ DOLERA JOSE. Presidente: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS. Vicepresid.: JIMENEZ RIBONPEDRO. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: afemefa.com. Datos registrales. T 21179 , F 65, S 8,H M 263849, I/A 22 ( 5.08.14).

20 de Marzo de 2014
Modificaciones estatutarias. 20. Convocotaria y Orden del D铆a. y 21 .Constituci贸n de la Asamblea General de Mutualistas; 22.-Funcionamiento de la Asamblea General de Mutualistas; 23. Competencias de la Asamblea General de Mutualistas; 24.-Concepto; 25.-Composici贸n; 26.-Reuniones del Consejo de Administraci贸n y adopci贸n de. Datos registrales. T 21179 , F 62, S 8, H M 263849, I/A21 (12.03.14).

26 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 21179 , F 61, S 8, H M 263849, I/A 20(16.12.13).

21 de Marzo de 2013
Nombramientos. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 21179 , F 61, S 8, H M 263849, I/A19 (11.03.13).

04 de Agosto de 2010
Nombramientos. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 21179 , F 61, S 8, H M 263849, I/A18 (26.07.10).

17 de Mayo de 2010
Nombramientos. Consejero: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS;JIMENEZ RIBON PEDRO;LOPEZ URIA ANGELJOSE;DOMINGUEZ RUIZ JOSE ENRIQUE;GARCIA SANMARTIN LUIS;RODRIGUEZ SESMA CARLOS;VAZQUEZ RODRIGUEZEMILIO;SORIA MARTINEZ MARIA TERESA;GIL BENAVIDES CARLOS;PRIETO BATANERO EDUARDO;MATA OROZCOFERNANDO;RONDAN FERNANDEZ JULIO;JIMENEZ DOLERA JOSE. Presidente: DE TORRES ASPIUNZA JUAN-LUIS. Vicepresid.:JIMENEZ RIBON PEDRO. Tesorero: LOPEZ URIA ANGEL JOSE. Secretario: GARCIA SANMARTIN LUIS. Vicesecret.: RODRIGUEZSESMA CARLOS. Vicetes.: DOMINGUEZ RUIZ JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 21179 , F 60, S 8, H M 263849, I/A 17 (6.05.10).

26 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. AdminProvi: BOIXASA SOLAGRAN JACINT. Otros conceptos: SE LEVANTA LA MEDIDA DE CONTROLADOPTADA POR RESOLUCION DE 26 DE MAYO DE 2008 POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n